GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED

GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC193483
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLADEDALE (EAST SCOTLAND) LIMITED25 jul 200825 jul 2008
    GLADEDALE (PARTNERSHIPS) LTD25 ene 200725 ene 2007
    BETT PARTNERSHIPS LIMITED26 may 200526 may 2005
    BETT HOMES (NORTH EAST SCOTLAND) LIMITED27 abr 200527 abr 2005
    BETT PARTNERSHIPS LIMITED18 mar 199918 mar 1999
    MITRESHELF 253 LIMITED16 feb 199916 feb 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 06 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2016

    28 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 nov 2016

    Estado de capital el 01 nov 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Solicitud de restauración administrativa

    3 páginasRT01

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT el 23 oct 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 mar 2015

    Estado de capital el 06 mar 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secretario
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147808920001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Director
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Director
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie-Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Angus
    Secretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Angus
    British606150011
    BISHOP & ROBERTSON CHALMERS
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secretario designado corporativo
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    900003620001
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Director
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    BAIRD, Ian Coid
    13 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    Director
    13 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    ScotlandBritish44063980001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CHURCH, Charles
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    Director
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    United KingdomBritish79873860001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOUGLAS, Keith Richard
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    Director
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    United KingdomBritish91229410003
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Director
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LANG, James Russell
    Flat 3f Melbourne Court
    Braid Park Drive Giffnock
    Glasgow
    Director designado
    Flat 3f Melbourne Court
    Braid Park Drive Giffnock
    Glasgow
    British900003610001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MACCOLL, Stuart Neil
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    Director
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish111800560001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Director
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish147233120001
    MILLAR, James Allan
    Laggan House
    Campsie Dene Road Blanefield
    Glasgow
    Director designado
    Laggan House
    Campsie Dene Road Blanefield
    Glasgow
    British900003600001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    RIDDLE, Andrew
    5 Clune Road
    KY12 9NZ Gowkhall
    Fife
    Director
    5 Clune Road
    KY12 9NZ Gowkhall
    Fife
    British117037490001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    06 abr 2016
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc024489
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 14 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 08 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2009Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 28 feb 2005
    Entregado el 10 mar 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Land at north-west side of glasgow road, dennyloanhead (title number stg 50880).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 mar 2005Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 21 nov 2003
    Entregado el 28 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due pursuant to the personal bond dated 20 may 2003
    Breve descripción
    6.12 acres at greenhill road, bonnybridge, county of stirling.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 nov 2003Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 23 may 2003
    Entregado el 30 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5.98 acres at greenhill road, bonnybridge.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 may 2003Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 23 may 2003
    Entregado el 30 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    3.769 hectares at harrysmuir road, houston industrial estate, livingston.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 may 2003Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 21 may 2003
    Entregado el 03 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 jun 2003Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 28 mar 2001
    Entregado el 04 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Heritable property at whitehill sidings, whitehill road, hamilton, lanarkshire.
    Personas con derecho
    • Scottish Homes
    Transacciones
    • 04 abr 2001Registro de un cargo (410)
    • 04 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0