GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC193483 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLADEDALE (EAST SCOTLAND) LIMITED | 25 jul 2008 | 25 jul 2008 |
| GLADEDALE (PARTNERSHIPS) LTD | 25 ene 2007 | 25 ene 2007 |
| BETT PARTNERSHIPS LIMITED | 26 may 2005 | 26 may 2005 |
| BETT HOMES (NORTH EAST SCOTLAND) LIMITED | 27 abr 2005 | 27 abr 2005 |
| BETT PARTNERSHIPS LIMITED | 18 mar 1999 | 18 mar 1999 |
| MITRESHELF 253 LIMITED | 16 feb 1999 | 16 feb 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 mar 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 feb 2016 | 28 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Solicitud de restauración administrativa | 3 páginas | RT01 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | 147808920001 | |||||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MASON, Eddie-Roy | Secretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Angus | British | 606150011 | ||||||
| BISHOP & ROBERTSON CHALMERS | Secretario designado corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900003620001 | |||||||
| ANDERSON, Alexander | Director | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||
| BAIRD, Ian Coid | Director | 13 Hatton View PH2 7DA Perth | Scotland | British | 44063980001 | |||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| CHURCH, Charles | Director | 6 Lynebank Grove Newton Mearns G77 5GB Glasgow | United Kingdom | British | 79873860001 | |||||
| DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOUGLAS, Keith Richard | Director | Lilac Cottage Castlehill Main Street FK8 3DN Kippen Stirlingshire | United Kingdom | British | 91229410003 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| HANNA, Ronald George | Director | 34 Primrose Bank Road EH5 3JF Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 8506940001 | |||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Director | Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow 35 Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| LANG, James Russell | Director designado | Flat 3f Melbourne Court Braid Park Drive Giffnock Glasgow | British | 900003610001 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MACCOLL, Stuart Neil | Director | 47 Murieston Valley Murieston EH54 9HJ Livingston West Lothian | Scotland | British | 111800560001 | |||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Director | 6 Cupar Road KY8 6DQ Lundin Links The Stables Fife United Kingdom | Scotland | British | 147233120001 | |||||
| MILLAR, James Allan | Director designado | Laggan House Campsie Dene Road Blanefield Glasgow | British | 900003600001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| RIDDLE, Andrew | Director | 5 Clune Road KY12 9NZ Gowkhall Fife | British | 117037490001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant Homes (Scotland) Limited | 06 abr 2016 | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 14 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 08 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 28 feb 2005 Entregado el 10 mar 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Land at north-west side of glasgow road, dennyloanhead (title number stg 50880). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 21 nov 2003 Entregado el 28 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due pursuant to the personal bond dated 20 may 2003 | |
Breve descripción 6.12 acres at greenhill road, bonnybridge, county of stirling. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 23 may 2003 Entregado el 30 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 5.98 acres at greenhill road, bonnybridge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 23 may 2003 Entregado el 30 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 3.769 hectares at harrysmuir road, houston industrial estate, livingston. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 may 2003 Entregado el 03 jun 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 28 mar 2001 Entregado el 04 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Heritable property at whitehill sidings, whitehill road, hamilton, lanarkshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0