SCOTTISH POWER LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SCOTTISH POWER LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC193794 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SCOTTISH POWER LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SCOTTISH POWER LIMITED?
| Dirección de la sede social | 320 St. Vincent Street G2 5AD Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTTISH POWER LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOTTISH POWER PLC | 30 jul 1999 | 30 jul 1999 |
| NEW SCOTTISH POWER PLC | 29 jul 1999 | 29 jul 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTTISH POWER LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SCOTTISH POWER LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTTISH POWER LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 129 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Wendy Jacqueline Barnes el 18 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Lord John Matthew Patrick Hutton como director el 06 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lesley Anne Glover como director el 26 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2025 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 oct 2024
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 54 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 132 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 132 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jose Ignacio Sanchez Galan el 03 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Keith Stuart Anderson el 03 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jose Sainz Armada el 03 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Daniel Alcain el 03 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Louise O'neill como director el 17 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 54 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 111 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Rt Hon. Claire Louise O'neill como director el 21 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Professor Dame Lesley Anne Glover como director el 21 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Olav Kerr of Kinlochard como director el 21 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2022 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SCOTTISH POWER LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENMAN, Marion | Secretario | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | British | 125700460002 | ||||||
| ALCAIN, Daniel | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Spain | Spanish | 268584180001 | |||||
| ANDERSON, Keith Stuart | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Scotland | British | 90495720003 | |||||
| BARNES, Wendy Jacqueline | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | England | British | 86508830005 | |||||
| CODES CALATRAVA, Gerardo | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Spain | Spanish | 265317640001 | |||||
| FERNANDEZ DE MESA VARGAS, Inigo, Sr | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Spain | Spanish | 253606050001 | |||||
| HUTTON, John Matthew Patrick, Lord | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | England | British | 335457260001 | |||||
| MCDONALD, James Rufus, Professor Sir | Director | 16 Richmond Street G1 1XQ Glasgow University Of Strathclyde, Mccance Building Scotland | Scotland | British | 42386710003 | |||||
| SAINZ ARMADA, Jose | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Spain | Spanish | 121274990003 | |||||
| SANCHEZ GALAN, Jose Ignacio | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Spain | Spanish | 121244680003 | |||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Secretario | 197 Queen Victoria Drive Scotstounhill G14 9BP Glasgow | British | 52720790003 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Secretario | 32 Highburgh Road Dowanhill G12 9EF Glasgow | British | 52720790002 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Secretario | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| STANLEY, Rupert James | Secretario | New School Farm 6 Station Road Tilbrook PE28 0JT Huntingdon Cambridgeshire | British | 50448490001 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ALCOLEA CANTOS, Jose Miguel | Director | Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow 1 Atlantic Quay | Spain | Spanish | 121243900002 | |||||
| BAILEY, Vicky Lynn Anderson | Director | 3101 New Mexico Avenue N.W. Apt.249 Washington D.C 20016 Usa | American | 98637010001 | ||||||
| BAIRD, Euan | Director | 131 East 66 Street - 4/5e New York 10021 America | British | 74636880001 | ||||||
| BARNES, Mair | Director | Ashe Ingen Court Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | 28547270003 | |||||
| BECKER ZUAZUA, Fernando | Director | 1 Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow | British | 121243890002 | ||||||
| BERRY, Charles Andrew | Director | 5 Grange Road Bearsden G61 3PL Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 109780690001 | |||||
| BOWMAN, Philip | Director | Scottish Power Plc 1 Atlantic Quay G2 8SP Glasgow | Australian | 62693560008 | ||||||
| BREWER, Nicola Mary, Dr. Dame | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | United Kingdom | British | 186840940001 | |||||
| BRYDON, Donald Hood | Director | 7 Newgate Street EC1A 7NX London | United Kingdom | British | 46914650006 | |||||
| CAMPBELL, John Alexander | Director | 1 Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow Scottish Power | Scotland | British | 148798390001 | |||||
| CARROLL JNR, Philip Joseph | Director | The Huntingdon 2121 Kirby Drive No.34s Houston Tx 77019 Usa | American | 93520950001 | ||||||
| CARROLL JNR, Philip Joseph | Director | The Huntingdon 2121 Kirby Drive No.34s Houston Tx 77019 Usa | American | 93520950001 | ||||||
| CRAIG, Mark | Director | 19/5 Russell Gardens EH12 5PP Edinburgh | British | 63130650001 | ||||||
| DEACON, Susan Catherine, Professor | Director | Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow 1 Scotland | United Kingdom | British | 127855030001 | |||||
| DEL VALLE DOBLADO, Jose Luis | Director | 1 Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow | British | 121243960002 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Director | 32 Highburgh Road Dowanhill G12 9EF Glasgow | British | 52720790002 | ||||||
| FARMER CBE, KCSG, Tom, Sir | Director | 192 Queensferry Road EH4 2BN Edinburgh Maidencraig House Midlothian | Scotland | British | 142653070001 | |||||
| FERNANDEZ, Ramon Antonio | Director | Sector Escultores 36 4b 28760 Tres Cantos FOREIGN Madrid Spain | Spanish | 121275520001 | ||||||
| FOX, Suzanne | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | United Kingdom | British | 292039080002 | |||||
| GARDNER, Anthony Luzzatto | Director | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | Italy | American | 236471530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SCOTTISH POWER LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spw Investments Limited | 06 abr 2016 | St. Vincent Street G2 5AD Glasgow 320 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0