TURNING POINT SCOTLAND
Visión general
| Nombre de la empresa | TURNING POINT SCOTLAND |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | SC194639 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TURNING POINT SCOTLAND?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
- Otras actividades de atención residencial n.c.p. (87900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra TURNING POINT SCOTLAND?
| Dirección de la sede social | Merchants House 7 West George Street G2 1BA Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TURNING POINT SCOTLAND?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TURNING POINT SCOTLAND?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TURNING POINT SCOTLAND?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancelación total de la carga 17 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 16 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 15 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 62 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Patricia Anne Cassidy el 25 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Smith como director el 19 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 59 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Miss Fiona Jane Walker como director el 10 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 22 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Louise Smith el 25 mar 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Alteraciones a la garantía flotante SC1946390023 | 14 páginas | 466(Scot) | ||||||||||
Alteraciones a la garantía flotante SC1946390022 | 14 páginas | 466(Scot) | ||||||||||
Registro de la carga SC1946390023, creada el 16 oct 2023 | 17 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga SC1946390022, creada el 09 oct 2023 | 23 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 58 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Allan James Clow como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Mcauslan como director el 12 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Murray Stuart Husband como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alexander Douglas Mclaren como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary William Brewer como director el 01 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 18 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TURNING POINT SCOTLAND?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC YOUNG LLP | Secretario corporativo | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House Scotland |
| 92309420007 | ||||||||||||||
| BUNCE, Alison | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 246941880001 | |||||||||||||
| CASSIDY, Patricia Anne | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 287067570001 | |||||||||||||
| CLOW, Allan James | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 183442130001 | |||||||||||||
| COOK, Graeme James | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 251910880001 | |||||||||||||
| GABBITAS, Peter | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 199332360001 | |||||||||||||
| GIBBS, Kathryn Lorna | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 260306630001 | |||||||||||||
| HUSBAND, Murray Stuart | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 192291560001 | |||||||||||||
| MAZZUCCO, Marc Paul | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | United Kingdom | British | 287067200001 | |||||||||||||
| MCLAREN, Alexander Douglas | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 261911830001 | |||||||||||||
| PLUMMER, Stephen Philip | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 164301050001 | |||||||||||||
| THOMSON, Jennifer | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 292103450001 | |||||||||||||
| WALKER, Fiona Jane | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 286551590001 | |||||||||||||
| ABRAHAM, Estella Emily | Director | The Sheiling Eshiels EH45 8NA Peebles | Scotland | British | 91059250002 | |||||||||||||
| ALEXANDER, Morag | Director | Achomraich Dull PH15 2JQ Aberfeldy Perthshire | British | 76313720007 | ||||||||||||||
| ALLAN, Callum Macphail | Director | Govan Road G51 1JL Glasgow 54 Scotland | Scotland | British | 1285600001 | |||||||||||||
| ARTACHO, Morgane | Director | Govan Road G51 1JL Glasgow 54 Scotland | Scotland | French | 136827650002 | |||||||||||||
| BELL, Graham Mcneil | Director | An Claggan Argyll Road Kilcreggan G84 0HU Helensburgh Dunbartonshire | Scotland | British | 43237490001 | |||||||||||||
| BOYD, Lesley Jane | Director | 11a Albert Terrace EH10 5EA Edinburgh | Scotland | British | 41253890003 | |||||||||||||
| BREWER, Gary William | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 292105290001 | |||||||||||||
| CAMERON, Thomas Anthony | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 130652200002 | |||||||||||||
| EDWARDS, Raymond | Director | Govan Road G51 1JL Glasgow 54 Scotland | Scotland | British | 108753780002 | |||||||||||||
| FAZAL, Sheila Elizabeth | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House Scotland | Scotland | British | 160863230001 | |||||||||||||
| FINDLAY, Craig William | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House Scotland | Scotland | British | 154496110001 | |||||||||||||
| GILDER, Paula Margaret | Director | 4 London Street EH3 6NA Edinburgh | British | 63151590001 | ||||||||||||||
| GRAY, Elizabeth Wood | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | Scottish | 137670260002 | |||||||||||||
| HAMILTON, Lindsay | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | United Kingdom | British | 116378730001 | |||||||||||||
| HAMILTON, Peter Farmer | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House Scotland | Scotland | British | 160864280001 | |||||||||||||
| HILL, Iain Burns | Director | 92 Hyndland Road G12 9PZ Glasgow Strathclyde | British | 40902170001 | ||||||||||||||
| HOWELL, Keith Martin | Director | Govan Road G51 1JL Glasgow 54 Scotland | Scotland | British | 1499960007 | |||||||||||||
| HOWELL, Keith Martin | Director | White Moss EH46 7BS West Linton Peeblesshire | Scotland | British | 1499960007 | |||||||||||||
| HOWELL, Keith Martin | Director | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | 1499960006 | ||||||||||||||
| HUGHES, Joseph Christopher | Director | Ashgrove House 3 St Andrews Avenue G71 8DN Bothwell | Scotland | British | 297812020001 | |||||||||||||
| ILLSLEY, Judith | Director | 64 Lauderdale Gardens G12 9QW Glasgow | British | 108753720001 | ||||||||||||||
| JAGPAL, Daradjeet | Director | 7 West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House | Scotland | British | 212716220001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para TURNING POINT SCOTLAND?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 25 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0