TURNING POINT SCOTLAND

TURNING POINT SCOTLAND

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTURNING POINT SCOTLAND
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC194639
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TURNING POINT SCOTLAND?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
    • Otras actividades de atención residencial n.c.p. (87900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra TURNING POINT SCOTLAND?

    Dirección de la sede social
    Merchants House
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TURNING POINT SCOTLAND?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TURNING POINT SCOTLAND?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta25 mar 2026
    Próxima declaración de confirmación vence08 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta25 mar 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TURNING POINT SCOTLAND?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cancelación total de la carga 17

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 16

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 15

    1 páginasMR04

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025

    62 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Ms Patricia Anne Cassidy el 25 mar 2025

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Louise Smith como director el 19 oct 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024

    59 páginasAA

    Nombramiento de Miss Fiona Jane Walker como director el 10 may 2024

    2 páginasAP01

    Memorándum y Estatutos

    22 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cambio de datos del director Mrs Louise Smith el 25 mar 2024

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Alteraciones a la garantía flotante SC1946390023

    14 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante SC1946390022

    14 páginas466(Scot)

    Registro de la carga SC1946390023, creada el 16 oct 2023

    17 páginasMR01

    Registro de la carga SC1946390022, creada el 09 oct 2023

    23 páginasMR01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023

    58 páginasAA

    Nombramiento de Mr Allan James Clow como director el 01 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Mcauslan como director el 12 sept 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Murray Stuart Husband como director el 01 sept 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Alexander Douglas Mclaren como director el 01 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gary William Brewer como director el 01 jul 2023

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 18

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de TURNING POINT SCOTLAND?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TC YOUNG LLP
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Secretario corporativo
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Forma jurídicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo de identificaciónOtra entidad corporativa o firma
    Autoridad legalLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Número de registroSO302634
    92309420007
    BUNCE, Alison
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish246941880001
    CASSIDY, Patricia Anne
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish287067570001
    CLOW, Allan James
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish183442130001
    COOK, Graeme James
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish251910880001
    GABBITAS, Peter
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish199332360001
    GIBBS, Kathryn Lorna
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish260306630001
    HUSBAND, Murray Stuart
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish192291560001
    MAZZUCCO, Marc Paul
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    United KingdomBritish287067200001
    MCLAREN, Alexander Douglas
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish261911830001
    PLUMMER, Stephen Philip
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish164301050001
    THOMSON, Jennifer
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish292103450001
    WALKER, Fiona Jane
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish286551590001
    ABRAHAM, Estella Emily
    The Sheiling
    Eshiels
    EH45 8NA Peebles
    Director
    The Sheiling
    Eshiels
    EH45 8NA Peebles
    ScotlandBritish91059250002
    ALEXANDER, Morag
    Achomraich Dull
    PH15 2JQ Aberfeldy
    Perthshire
    Director
    Achomraich Dull
    PH15 2JQ Aberfeldy
    Perthshire
    British76313720007
    ALLAN, Callum Macphail
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Director
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandBritish1285600001
    ARTACHO, Morgane
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Director
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandFrench136827650002
    BELL, Graham Mcneil
    An Claggan Argyll Road
    Kilcreggan
    G84 0HU Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    An Claggan Argyll Road
    Kilcreggan
    G84 0HU Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish43237490001
    BOYD, Lesley Jane
    11a Albert Terrace
    EH10 5EA Edinburgh
    Director
    11a Albert Terrace
    EH10 5EA Edinburgh
    ScotlandBritish41253890003
    BREWER, Gary William
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish292105290001
    CAMERON, Thomas Anthony
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish130652200002
    EDWARDS, Raymond
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Director
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandBritish108753780002
    FAZAL, Sheila Elizabeth
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    ScotlandBritish160863230001
    FINDLAY, Craig William
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    ScotlandBritish154496110001
    GILDER, Paula Margaret
    4 London Street
    EH3 6NA Edinburgh
    Director
    4 London Street
    EH3 6NA Edinburgh
    British63151590001
    GRAY, Elizabeth Wood
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandScottish137670260002
    HAMILTON, Lindsay
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    United KingdomBritish116378730001
    HAMILTON, Peter Farmer
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    ScotlandBritish160864280001
    HILL, Iain Burns
    92 Hyndland Road
    G12 9PZ Glasgow
    Strathclyde
    Director
    92 Hyndland Road
    G12 9PZ Glasgow
    Strathclyde
    British40902170001
    HOWELL, Keith Martin
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Director
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandBritish1499960007
    HOWELL, Keith Martin
    White Moss
    EH46 7BS West Linton
    Peeblesshire
    Director
    White Moss
    EH46 7BS West Linton
    Peeblesshire
    ScotlandBritish1499960007
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Director
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    British1499960006
    HUGHES, Joseph Christopher
    Ashgrove House
    3 St Andrews Avenue
    G71 8DN Bothwell
    Director
    Ashgrove House
    3 St Andrews Avenue
    G71 8DN Bothwell
    ScotlandBritish297812020001
    ILLSLEY, Judith
    64 Lauderdale Gardens
    G12 9QW Glasgow
    Director
    64 Lauderdale Gardens
    G12 9QW Glasgow
    British108753720001
    JAGPAL, Daradjeet
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Director
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish212716220001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para TURNING POINT SCOTLAND?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    25 mar 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0