IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC200801 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 7 Castle Street EH2 3AH Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RESOLUTION ASSET MANAGEMENT LIMITED | 02 may 2006 | 02 may 2006 |
| BRITANNIC ASSET MANAGEMENT LIMITED | 08 dic 1999 | 08 dic 1999 |
| DUNWILCO (737) LIMITED | 19 oct 1999 | 19 oct 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 jun 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 George Street Edinburgh EH2 2LL United Kingdom a 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH el 11 abr 2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2022 au 30 jun 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 6 st Andrews Square Edinburgh Midlothian EH2 2BD United Kingdom a 1 George Street Edinburgh EH2 2LL | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital el 22 ago 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graeme James Mcbirnie como director el 01 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Andrew Emile Winter como director el 28 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Sla Corporate Secretary Limited el 26 nov 2021 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Modification des détails de Standard Life Investments (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stuart Lapsley Maclennan como director el 22 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Baird Aird como director el 22 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Sla Corporate Secretary Limited como secretario el 31 jul 2021 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Holly Sylvia Kidd como secretario el 31 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRDN CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom |
| 268172630002 | ||||||||||
| MACLENNAN, Stuart Lapsley | Director | Castle Street EH2 3AH Edinburgh 7 | Scotland | British | 177977290003 | |||||||||
| MCBIRNIE, Graeme James | Director | Castle Street EH2 3AH Edinburgh 7 | United Kingdom | British | 183068680001 | |||||||||
| GRIFFIN, Stephanie Rose | Secretario | 70 Marlborough Avenue Broomhill G11 7BH Glasgow 1/1, United Kingdom | 154523420001 | |||||||||||
| HANKIN, Christina Ann | Secretario | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | 197326520001 | |||||||||||
| KIDD, Holly Sylvia | Secretario | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | 205019060001 | |||||||||||
| WAGNER, Deborah Anne | Secretario | 1 Hillend Road Burnside G73 4JU Glasgow | British | 6059110004 | ||||||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||||||
| ACHESON, Alan Stephen | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 121105970002 | |||||||||
| ADAM, Ian C | Director | Gowanfield 2 Cammo Road EH4 8EB Edinburgh | Scotland | British | 37076220001 | |||||||||
| AIRD, James Baird | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 94017920003 | |||||||||
| ALLVEY, David Philip | Director | Greenside House 50 Station Road N22 7TP London | British | 76454860013 | ||||||||||
| BANNISTER, Clive Christopher Roger | Director | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | England | British | 38206210004 | |||||||||
| BAYLEY, Trevor John | Director | Woodside Clay Lake Endon ST9 9DD Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 804490002 | |||||||||
| BIGGS, Michael Nicholas | Director | The Red House Little Almshoe St Ippollitts SG4 7NP Hitchin Hertfordshire | United Kingdom | British | 169003260001 | |||||||||
| CASSONI, Maria Luisa | Director | 125 Providence Square Bermondsey Wall West SE1 2ED London | England | British | 74583340001 | |||||||||
| CHENE, Claude Andre | Director | Mapesbury Road NW2 4JD London 28 England England | England | British,American | 109424970002 | |||||||||
| CLARK, Colin Martin | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | England | British | 30274870010 | |||||||||
| CLUTTERBUCK, Fiona Jane | Director | 13 Downshire Hill Hampstead NW3 1NR London | England | British | 30329430001 | |||||||||
| COOK, Robert Derek | Director | Dagnan Road SW12 9LQ London 4 United Kingdom | England | British | 133276790001 | |||||||||
| COTTAM, Harold, Managing Director | Director | Pentwyn Farm Dorstone HR3 6AD Hereford | United Kingdom | British | 32116700002 | |||||||||
| CRAWFORD, Douglas James | Director | 37 The Steils EH10 5XD Edinburgh | British | 55793670001 | ||||||||||
| CROSS BROWN, Tom | Director | Shipton Old Farm MK18 3JL Winslow Buckinghamshire | United Kingdom | English | 154509390001 | |||||||||
| CUMMINS, Diarmuid | Director | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | England | British | 78791890003 | |||||||||
| CUSINS, John Robert | Director | High Gables Holly Lane AL5 5DY Harpenden Hertfordshire | England | British | 107782060002 | |||||||||
| DEWAR-DURIE, Andrew Maule | Director | Finnich Malise G63 0HA Croftamie Stirlingshire | Scotland | British | 73128130001 | |||||||||
| DIXON, Paul Robert | Director | Halsey Street SW3 2QH London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 93980300001 | |||||||||
| FELLINGHAM, Christopher James | Director | Spring Lane Great Horwood MK17 0QU Milton Keynes Spring Farm England England | United Kingdom | British | 142527740001 | |||||||||
| FERRANS, Douglas | Director | 9 Lochbroom Drive Newton Mearns G77 5DY Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 1166720002 | |||||||||
| FITZGERALD, Sean Andrew | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 166747610001 | |||||||||
| FORTIN, Richard Chalmers Gordon | Director | Philliswood Farm House Hooksway PO18 9JZ Chichester West Sussex | United Kingdom | British | 31479720002 | |||||||||
| GHILONI, Francis William | Director | 63 Lauderdale Gardens Hyndland G12 9QU Glasgow | British | 75953650003 | ||||||||||
| LAIRD, Gavin Harry, Sir | Director | 9 Cleveden House Holmbury Park BR1 2WG Bromley Kent | British | 127153740001 | ||||||||||
| MCCONVILLE, James | Director | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | British | 72663840004 | |||||||||
| MCINTOSH, Leslie Kynoch | Director | Denrhoda, 6 Seven Sisters Lenzie G66 3AW Glasgow | British | 51135930001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrdn Investments (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene IGNIS ASSET MANAGEMENT LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0