INTENSE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INTENSE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC202087 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTENSE LIMITED?
- (3210) /
- (7310) /
¿Dónde se encuentra INTENSE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Lochside Place EH12 9RG Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTENSE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTENSE PHOTONICS LIMITED | 03 mar 2000 | 03 mar 2000 |
| DUNWILCO (754) LIMITED | 02 dic 1999 | 02 dic 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTENSE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTENSE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 6 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 4 Stanley Boulevard Hamilton Int Tech Park Blantyre, Glasgow G72 0BN el 13 may 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 11 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 42 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Alteraciones a la garantía flotante 9 | 5 páginas | 466(Scot) | ||||||||||||||||||
legacy | 5 páginas | MG01s | ||||||||||||||||||
legacy | 5 páginas | MG01s | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 13 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Dr Berthold Elmar Schmidt el 02 dic 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Professor John Haig Marsh el 02 dic 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02s | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Snowden como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Wolfers como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Paul Anthony Murray como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 nov 2009
| 32 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 36 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Lobley como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 34 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Scott Sommervaille Christie el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Graeme Ross Alexander el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Brian Williamson el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Peter Benjamin Wolfers el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INTENSE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMSON, Brian | Secretario | 4 Stanley Boulevard Hamilton Int Tech Park G72 0BN Blantyre, Glasgow | British | 112212850002 | ||||||
| ALEXANDER, Graeme Ross | Director | 4 Stanley Boulevard Hamilton Int Tech Park G72 0BN Blantyre, Glasgow | Scotland | British | 62307000003 | |||||
| CHRISTIE, Scott Sommervaille | Director | 4 Stanley Boulevard Hamilton Int Tech Park G72 0BN Blantyre, Glasgow | Scotland | British | 104262520001 | |||||
| MARSH, John Haig, Professor | Director | 1 Bellshaugh Gardens G12 0SA Glasgow | United Kingdom | British | 62379460001 | |||||
| MURRAY, Paul Anthony | Director | Buckingham Gate SW1E 6LB London 14 | England | British | 97405130002 | |||||
| ROBERTSON, Iain Malcolm | Director | Merry Hills Cottage Merry Hills Lane RH14 0RB Loxwood West Sussex | United Kingdom | British | 30965630001 | |||||
| SCHMIDT, Berthold Elmar, Dr | Director | CH8045 Jona-Kempraten Oberer Gubel 51 Switzerland | Switzerland | German | 139191190001 | |||||
| HAMBLETON, Helen Louise | Secretario | Westfield Cottage Edinburgh Road ML12 6QX Biggar South Lanarkshire | British | 77683860005 | ||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| ANDERSON, James Iain Walker | Director | Burnbank Acharn PH15 2HU Aberfeldy Perthshire | British | 71562850004 | ||||||
| BORDUI, Peter | Director | De Els 6 5553 CW Valkenswaard Netherlands | American | 80434550001 | ||||||
| CHAPMAN, Stuart Malcolm | Director | High Mead Highercombe Road GU27 2LH Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 98452660001 | |||||
| CRAWFORD, Douglas James | Director designado | 37 The Steils EH10 5XD Edinburgh | British | 900017100001 | ||||||
| HAMILTON, Craig James | Director | 45 Lamont Avenue PA7 5LJ Bishopton | British | 68893260002 | ||||||
| HASTINGS, Gillian Elizabeth | Director | 1/1 17 Polworth Street G12 9UD Glasgow Lanarkshire | British | 78330220001 | ||||||
| HOLME, Catrina | Director | 3 Battledean Road N5 1UX London | England | British | 87092660002 | |||||
| LEWANDOWSKI, Kenneth Macdonald Arthur | Director | 5 Allanwater Gardens Bridge Of Allan FK9 4DW Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 14010460001 | |||||
| LOBLEY, Ian Matthew | Director | Wick Hill Lodge The Ridges Finchampstead RG40 3SS Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 48956790004 | |||||
| LOCKWOOD, David Charles | Director | EH9 | British | 69836380001 | ||||||
| MCDONALD, Walter Don | Director | 67 Cleveden Road G12 0JN Glasgow | American | 96685120001 | ||||||
| MORITZ, Thomas Oakes | Director | 37 Dundee Road NJ 08824 Kendall Park Usa | American | 119877750001 | ||||||
| O'SULLIVAN, John | Director | 68 Radcliff Hall St John Road D4 Sandymound Dunblin Ireland | Irish | 78404970001 | ||||||
| POLSON, Michael Buchanan | Director | 11 Craighall Gardens EH6 4RH Edinburgh | British | 46168760001 | ||||||
| SNOWDEN, Christopher Maxwell, Professor | Director | Blackwell House Hog's Back GU3 1DF Guildford Surrey | England | British | 105171210001 | |||||
| WOLFERS, Peter Benjamin | Director | c/o First Capital Fulham Palace Road W6 8JA London 77 United Kingdom | United Kingdom | British | 72173650002 |
¿Tiene INTENSE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 12 ene 2010 Entregado el 20 ene 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada Obligations in terms of the lease | |
Breve descripción 4 stanley boulevard blantyre glasgow lan 120895. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 12 ene 2010 Entregado el 20 ene 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada Obligations in terms of the lease | |
Breve descripción 4 stanley boulevard blantyre glasgow LAN120895. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 05 nov 2007 Entregado el 15 nov 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 4 stanley boulevard, blantyre, glasgow LAN120895. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 08 oct 2007 Entregado el 18 oct 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 10 oct 2005 Entregado el 19 oct 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 12 abr 2005 Entregado el 21 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The subjects comprising and known as site 2B (otherwise known as 4 stanley boulevard), hamilton international technology park, blantyre lan 120895. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 01 abr 2005 Entregado el 12 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Deed of variation | Creado el 08 mar 2004 Entregado el 17 mar 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums and obligations due or which may become due by intense photonics limited to barclays bank | |
Breve descripción Site 2B hamilton international park, blantyre--title number LAN120895. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 22 abr 2002 Entregado el 29 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Site 2B, hamilton international technology park, stanley boulevard, blantyre. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 10 abr 2002 Entregado el 16 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 08 nov 2001 Entregado el 27 nov 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the financing documents | |
Breve descripción The whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time, while the floating charge is in force, be comprised in the property and undertaking of the company but excluding the "excluded assets" (see microfiche for details of "excluded assets"). Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 17 may 2001 Entregado el 24 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0