PEMBERTON CARE LIMITED

PEMBERTON CARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPEMBERTON CARE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC203716
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PEMBERTON CARE LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra PEMBERTON CARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor 115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PEMBERTON CARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PACIFIC SHELF 923 LIMITED08 feb 200008 feb 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PEMBERTON CARE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PEMBERTON CARE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 feb 2026
    Próxima declaración de confirmación vence22 feb 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 feb 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PEMBERTON CARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Jeanette Leach como director el 09 dic 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Isaac Akintayo como director el 09 dic 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mr Isaac Akintayo como director el 12 jul 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andy Muir como director el 12 jul 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Rebecca Tamara Massey como director el 16 mar 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Andy Muir como director el 28 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark William Grinonneau como director el 28 oct 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Lesley Alison Mcgregor como director el 14 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Wayne Michael Ashton como director el 14 oct 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    26 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christine Desiree Winstanley como director el 31 mar 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Wayne Michael Ashton como director el 31 mar 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Mark William Grinonneau como director el 07 dic 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Geoffrey Ward como director el 07 dic 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de PEMBERTON CARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARTLEY, Jeremy Peter
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    EnglandBritish118857570001
    LEACH, Jeanette
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish330428190001
    MASSEY, Rebecca Tamara
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish307277630001
    MCGREGOR, Lesley Alison
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish287867170001
    JOHNSTON, David Weir Cameron
    Stranadarrif
    Greenock Road
    PA4 9LB Inchinnan
    Renfrewshire
    Secretario
    Stranadarrif
    Greenock Road
    PA4 9LB Inchinnan
    Renfrewshire
    British39120630001
    MILLER, Janette Michele
    Chanters Farm
    Chanters Avenue, Atherton
    M46 9EF Manchester
    Secretario
    Chanters Farm
    Chanters Avenue, Atherton
    M46 9EF Manchester
    British51677270003
    RAWLINSON, Deborah Jane
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretario
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    209519390001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    AKINTAYO, Isaac
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    England
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    England
    EnglandBritish323190420001
    ANDERSON, Patricia Ann
    Sceptre Way
    PR5 6AW Bamber Bridge
    Sceptre House
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    PR5 6AW Bamber Bridge
    Sceptre House
    United Kingdom
    EnglandBritish197968260001
    ASHTON, Wayne Michael
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish256478460001
    CARTER, James Francis
    Pear Tree Cottage
    Pear Tree Lane
    PR7 6DU Euxton
    Lancashire
    Director
    Pear Tree Cottage
    Pear Tree Lane
    PR7 6DU Euxton
    Lancashire
    EnglandBritish10423690002
    CLAXTON, Humphrey Kenneth Haslam
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    United KingdomBritish87740250001
    COLLIER, Michael Edward
    Chanters Farmhouse
    Chanters Avenue
    M46 9EF Atherton
    Manchester
    Director
    Chanters Farmhouse
    Chanters Avenue
    M46 9EF Atherton
    Manchester
    EnglandBritish13163480002
    DAY, Mark
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    EnglandBritish157242280001
    FITZGERALD, Brian John Peter
    The Gable South Avenue
    Thornliepark
    PA2 7SP Paisley
    Renfrewshire
    Director
    The Gable South Avenue
    Thornliepark
    PA2 7SP Paisley
    Renfrewshire
    British37064300002
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Director
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritish50219540001
    GRICE, Neil Keith
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish182538290001
    GRINONNEAU, Mark William
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    Director
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    United KingdomBritish323896400001
    HARDY, Adrian Paul
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    United Kingdom
    EnglandBritish7158890001
    HEMMING, Eric Rodney
    24 Great King Street
    Edinburgh
    EH3 6QN
    Director
    24 Great King Street
    Edinburgh
    EH3 6QN
    EnglandBritish84030950002
    JOHNSTON, David Weir Cameron
    Stranadarrif
    Greenock Road
    PA4 9LB Inchinnan
    Renfrewshire
    Director
    Stranadarrif
    Greenock Road
    PA4 9LB Inchinnan
    Renfrewshire
    British39120630001
    MEIKLE, Stewart Robert
    20 Belford Gardens
    EH4 3EW Edinburgh
    Director
    20 Belford Gardens
    EH4 3EW Edinburgh
    ScotlandBritish70911700001
    MUIR, Andy
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    Director
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish289273870001
    NICOLL, Peter William, Mr.
    32 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4BS Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    32 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4BS Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish287380001
    ROWE, Peter
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Great Britain
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Great Britain
    United KingdomBritish162029690001
    SPENCE, Graham Michael
    Sceptre Way
    PR5 6AW Bamber Bridge
    Sceptre House
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    PR5 6AW Bamber Bridge
    Sceptre House
    United Kingdom
    United KingdomBritish155741260001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Director
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    TURPIN, Richard
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Great Britain
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Great Britain
    United KingdomBritish147202400001
    WARD, Neil Geoffrey
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish64005130002
    WARD, Neil Geoffrey
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Great Britain
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Great Britain
    United KingdomBritish64005130002
    WINSTANLEY, Christine Desiree
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish197967020001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Director designado corporativo
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PEMBERTON CARE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Sceptre House
    Lancashire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUk Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04934382
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0