CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED

CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa SC203999
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED?

    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Certificado de registro de una Sociedad de Socorros Mutuos

    páginasCERTIPS

    Misceláneos

    Fca's form b & form z converting company into a mutual society.
    2 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    The company has been converted into a community benefit society 10/03/2016
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2016, aucune liste de membres fournie

    10 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    30 páginasAA

    Cambio de datos del director Councillor William Goldie el 18 nov 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2015, aucune liste de membres fournie

    10 páginasAR01

    Misceláneos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    29 páginasAA

    Cese del nombramiento de Craig Jon Moule como secretario el 26 ago 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ms Sophie Atkinson como secretario el 26 ago 2014

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2014, aucune liste de membres fournie

    11 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Christina Anderson como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    28 páginasAA

    Nombramiento de Mr Adam Gordon Alexander Smith como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2013, aucune liste de membres fournie

    9 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    30 páginasAA

    Nombramiento de Councillor William Goldie como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Councillor Allan George Graham como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Christina Anderson como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Hugh Gough como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daniel Carrigan como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 16 feb 2012, aucune liste de membres fournie

    10 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    27 páginasAA

    Cese del nombramiento de William Homer como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ATKINSON, Sophie
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Secretario
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    190472660001
    CLARK, Alexander Hendry Murdoch
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishNone56184990005
    GOLDIE, William, Councillor
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandScottishSenior Biomedical Scientist122816950001
    GRAHAM, Allan George
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishInformation Trainer/Presenter And Councillor171814150001
    HOMER, Alice
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired106696650002
    JONES, Frances Jane
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishHousing Officer133551860001
    KNOX, Williamina
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishP/T Clerkess135250840001
    MACKENZIE, George Murray
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCounsellor75484200001
    PAYNE, John
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishNone85918780001
    SMITH, Adam Gordon Alexander
    Tarbolton Road
    Cumbernauld
    G67 2AF Glasgow
    5a
    Scotland
    Director
    Tarbolton Road
    Cumbernauld
    G67 2AF Glasgow
    5a
    Scotland
    ScotlandBritishCivil Servant177770160001
    WEST, Alan Findlay
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinancial Consultant83185920001
    HANVEY, John Howie
    33 St Marys Drive
    PH2 7BY Perth
    Perthshire
    Secretario
    33 St Marys Drive
    PH2 7BY Perth
    Perthshire
    British368510001
    HOPE, Colin Douglas
    6 Thornyhall
    Dalkeith
    EH22 2ND Midlothian
    Secretario
    6 Thornyhall
    Dalkeith
    EH22 2ND Midlothian
    BritishChief Executive88762600001
    INGLIS, William
    38a Clouden Road
    Kildrum
    G67 2EW Cumbernauld
    Lanarkshire
    Secretario
    38a Clouden Road
    Kildrum
    G67 2EW Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired72806780002
    MAXWELL, William Lowrie Maxwell
    23 Alder Road
    Abronhill
    G67 3AD Cumbernauld
    Lanarkshire
    Secretario
    23 Alder Road
    Abronhill
    G67 3AD Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired105150520001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Secretario
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    British146507680001
    LEDINGHAM CHALMERS
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secretario designado corporativo
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003330001
    ANDERSON, Christina
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Director
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    United KingdomBritishRetired165829820001
    BARRIE, Michael
    70 Beechwood Road
    Cumbernauld
    G67 2NP Lanarkshire
    Director
    70 Beechwood Road
    Cumbernauld
    G67 2NP Lanarkshire
    BritishRetired85525040001
    BOWIE, Rose Lafferty Richardson
    68 Greenrigg Road
    Cumbernauld
    G67 2PR Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    68 Greenrigg Road
    Cumbernauld
    G67 2PR Glasgow
    Lanarkshire
    BritishHousewife71104020001
    BROTHERTON, Colin
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    Director
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    BritishBank Manager92611530001
    BROTHERTON, Colin
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    Director
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    BritishBank Manager92611530001
    CARRIGAN, Daniel, Councillor
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCouncillor122150310001
    CLARK, Alexander Hendry Murdoch
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired56184990005
    DUNCAN, Brian David
    12d Campbell House
    Berryhill Road
    G67 1LX Cumbernauld
    North Lanark
    Director
    12d Campbell House
    Berryhill Road
    G67 1LX Cumbernauld
    North Lanark
    BritishRetired76879350001
    DUNPHY, Elizabeth
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    Director
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    United KingdomBritishDirector94022840001
    DUNPHY, Elizabeth
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    Director
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    United KingdomBritishRetired94022840001
    EDGAR, Frances
    96 Torbrex Road
    G67 2JS Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    96 Torbrex Road
    G67 2JS Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishHomemaker119688920001
    GODFREY, Robert Paton Miller
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired105357990001
    GODFREY, Robert Paton Miller
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired105357990001
    GOLDIE, William, Councillor
    40 Halidon Avenue
    G67 4FB Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    40 Halidon Avenue
    G67 4FB Cumbernauld
    Lanarkshire
    ScotlandScottishDirector122816950001
    GOUGH, Hugh
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired116338470001
    GOUGH, Hugh
    91 Torbrex Road
    G67 2JX Cumbernauld
    Lanarkshire
    Director
    91 Torbrex Road
    G67 2JX Cumbernauld
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired116338470001
    HARDY, Mary Motherwell
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Director
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired119687270001
    HENDRIE, Ann
    4a Wallace House
    Berryhill Road, Cumbernauld
    G67 1LU Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    4a Wallace House
    Berryhill Road, Cumbernauld
    G67 1LU Glasgow
    Lanarkshire
    BritishRetired68314870001

    ¿Tiene CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 31 mar 2004
    Entregado el 20 abr 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5B,5C,5D,6A,6B,6C,6D,7A,7C,7D,8C,9A elliot house, kildrum; 1,11,13,15,17,19,21,23,25,27,3,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,5,51,53,55,57,59,61,7,9,liddell road, ravenswood; 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34 beechwood court, carbrain; 1A,10B,11A,11C,11D,2A,2B,2C,2D,3A,3B,3C,4A,4B,4C,4D,5A elliot house, kildrum,all cumbernauld.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 20 abr 2004Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 14 dic 2000
    Entregado el 29 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £20,000,000
    Breve descripción
    Carbrain estate, ravenswood estate, seafar estate, muirhead estate, kildrum estate and village estate, all cumbernauld.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 29 dic 2000Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 14 dic 2000
    Entregado el 29 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £20,000,000
    Breve descripción
    Superiority of carbrain estate, ravenswood estate, seafar estate, muirhead estate, kildrum estate and village estate, all cumbernauld.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 29 dic 2000Registro de un cargo (410)
    Bond & floating charge
    Creado el 20 nov 2000
    Entregado el 24 nov 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 24 nov 2000Registro de un cargo (410)
    • 10 nov 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (MG05s)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0