PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC204626 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
- Agencias inmobiliarias (68310) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
Dirección de la sede social | 11 Whitehall Crescent DD1 4AR Dundee Scotland |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 15 mar 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Brian Marnoch como director el 07 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 9 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Peter Gordon Ryder como director el 01 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Lindsay Duncan Gunn Darroch como director el 01 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Hugh Derek Mckay como director el 19 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kenneth William Thomson como director el 19 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 6 South Saint Johns Place Perth Perthshire PH1 5SU a 11 Whitehall Crescent Dundee DD1 4AR el 06 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher John Todd como director el 18 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Barry George Dewar como director el 21 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alan John Baillie como director el 31 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2021 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Alistair Graham Napier como director el 31 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2020 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Tspc Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mar 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Perthshire Solicitors Property Centre (Holdings) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mar 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2019 | 10 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Lindsay Duncan Gunn Darroch como director el 12 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THORNTONS LAW LLP | Secretario corporativo | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland |
| 118364410001 | ||||||||||
BROWN, Michael Andrew | Director | DD1 1NR Dundee 17 South Tay Street Scotland | Scotland | British | Solicitor | 257815200001 | ||||||||
COUSTON, Robert James Gair | Director | DD9 6EG Brechin 31a St David Street Angus Scotland | Scotland | Scottish | Solicitor | 105453410001 | ||||||||
DARROCH, Lindsay Duncan Gunn | Director | DD1 1QN Dundee 2 West Marketgait Scotland | Scotland | British | Solicitor | 257815310001 | ||||||||
DEWAR, Barry George | Director | DD11 1HL Arbroath 78 High Street | Scotland | Scottish | Solicitor | 306098420001 | ||||||||
RYDER, Peter Gordon | Director | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | Scotland | British | Managing Director | 316934900001 | ||||||||
TODD, Christopher John | Director | 18 Greenmarket DD1 4QB Dundee Seabraes House Scotland | Scotland | British | Solicitor | 306098610001 | ||||||||
GEDDES, David James Irving | Secretario | West High Street PH7 4PU Crieff 25 Perthshire Scotland | 226387930001 | |||||||||||
HODGE, Alison Margaret | Secretario | Calton Street PH13 9AJ Coupar Angus Union Bank Buildings Perthshire Scotland | British | 182302830001 | ||||||||||
REID, David William | Secretario | Greenhill 19 Brompton Terrace PH2 7DQ Perth Perthshire | British | Solicitor | 69128200001 | |||||||||
WEBSTER, Mark | Secretario | Clachbeag Tibbermore PH1 1QJ Perth Perthshire | British | Solicitor | 205040002 | |||||||||
ALLAN, Crawford William | Director | Barossa Place PH1 5JX Perth 10 Perthshire Scotland | United Kingdom | British | Solicitor | 198314350001 | ||||||||
ANDERSON, Alastair Hamilton | Director | Viewmount Bellpark Park PH2 7AJ Perth | Scotland | Scottish | Solicitor | 31277380001 | ||||||||
BAILLIE, Alan John | Director | DD1 4BS Dundee 37 Union Street Scotland | Scotland | British | Solicitor | 105451350001 | ||||||||
BOLTON, Robert Buchanan Alexander | Director | Ruchilside Comrie PH6 2HU Crieff Perthshire | Scotland | British | Solicitor | 69128140001 | ||||||||
DARROCH, Lindsay Duncan Gunn | Director | DD1 4AR Dundee 9 Whitehall Crescent Scotland | Scotland | British | Solicitor | 257815310001 | ||||||||
DAVIES, Alan Graham | Director | 6 Kincarrathie Crescent PH2 7HH Perth Perth & Kinross | Scotland | British | Solicitor | 88605190001 | ||||||||
FRENZ, Amanda Jane | Director | 32 Muirfield PH1 1JJ Perth Perthshire | Scotland | British | Solicitor | 83079900002 | ||||||||
GEDDES, David James Irving | Director | West High Street PH7 4AU Crieff 25 | Scotland | British | Solicitor | 85319610002 | ||||||||
GRAY, John Paterson | Director | Embden House Newton Street PH10 6SU Blairgowrie Perthshire | United Kingdom | British | Solicitor Writer To The Signet | 90036430001 | ||||||||
HART, John Miller | Director | The Studio High Street PH10 6ET Blairgowrie Perthshire | British | Solicitor | 69128280001 | |||||||||
HART, John Millar | Director | Gregorton Brucefield Road,Rosemount PH10 6LA Blairgowrie Perthshire | Scotland | British | Solicitor | 69128280002 | ||||||||
HODGE, Alison Margaret | Director | Forneth PH8 0HE Dunkeld Greencrook Perthshire | Scotland | British | Solicitor | 140261940001 | ||||||||
MACDUFF-DUNCAN, Robert Simon | Director | Charlotte Street PH1 5LL Perth 8 Perthshire United Kingdom | Scotland | British | Solicitor | 107806500002 | ||||||||
MARNOCH, Brian | Director | Hamilton Place PH1 1BB Perth 14 | Scotland | British | None | 69128390003 | ||||||||
MARNOCH, Brian | Director | 14 Hamilton Place PH1 1BB Perth Perthshire | Scotland | British | Solciitor | 69128390003 | ||||||||
MCKAY, Hugh Derek | Director | DD1 4PA Dundee 136-138 Nethergate Scotland | Scotland | Scottish | Solicitor | 105451590001 | ||||||||
NAPIER, Alistair Graham | Director | Taypark Isla Road PH2 7HQ Perth Perthshire | Scotland | British | Solicitor | 1025000001 | ||||||||
REID, David William | Director | Greenhill 19 Brompton Terrace PH2 7DQ Perth Perthshire | United Kingdom | British | Solicitor | 69128200001 | ||||||||
THOMSON, Kenneth William | Director | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | Scotland | British | Solicitor | 105451200003 | ||||||||
WEBSTER, Mark | Director | Clachbeag Tibbermore PH1 1QJ Perth Perthshire | Scotland | British | Solicitor | 205040002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tspc Holdings Limited | 01 mar 2019 | Whitehall Crescent DD1 4AR Dundee 11 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Perthshire Solicitors Property Centre (Holdings) Ltd | 06 abr 2016 | South St. Johns Place PH1 5SU Perth 6 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0