PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED

PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC204626
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    • Agencias inmobiliarias (68310) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Whitehall Crescent
    DD1 4AR Dundee
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2025
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 mar 2026
    Próxima declaración de confirmación vence15 mar 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta01 mar 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XDYBRCUJ

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2024

    9 páginasAA
    XDV5A0PU

    Cese del nombramiento de Brian Marnoch como director el 07 jun 2024

    1 páginasTM01
    XDGQXE1U

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XCYQWBC0

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2023

    9 páginasAA
    XCUUBAU3

    Nombramiento de Mr Peter Gordon Ryder como director el 01 nov 2023

    2 páginasAP01
    XCI67UYH

    Nombramiento de Mr Lindsay Duncan Gunn Darroch como director el 01 abr 2023

    2 páginasAP01
    XCI67I4I

    Cese del nombramiento de Hugh Derek Mckay como director el 19 sept 2023

    1 páginasTM01
    XCHT0XCB

    Cese del nombramiento de Kenneth William Thomson como director el 19 sept 2023

    1 páginasTM01
    XCHT0WEB

    Domicilio social registrado cambiado de 6 South Saint Johns Place Perth Perthshire PH1 5SU a 11 Whitehall Crescent Dundee DD1 4AR el 06 dic 2023

    1 páginasAD01
    XCHSZZY3

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2022

    9 páginasAA
    XC0BT3PC

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XBYGBNXL

    Nombramiento de Mr Christopher John Todd como director el 18 oct 2022

    2 páginasAP01
    XBYGAM09

    Nombramiento de Mr Barry George Dewar como director el 21 jun 2022

    2 páginasAP01
    XBYGAKU8

    Cese del nombramiento de Alan John Baillie como director el 31 oct 2022

    1 páginasTM01
    XBYGAK5C

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2021

    8 páginasAA
    XB61TJI0

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XAZXSQUX

    Cese del nombramiento de Alistair Graham Napier como director el 31 oct 2021

    1 páginasTM01
    XAGFE8MG

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2020

    7 páginasAA
    SA7R9UIH

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XA0BHPEB

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X945ZW0O

    Notification de Tspc Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mar 2019

    2 páginasPSC02
    X945Z60R

    Cessation de Perthshire Solicitors Property Centre (Holdings) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mar 2019

    1 páginasPSC07
    X943E1H6

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2019

    10 páginasAA
    S9295H77

    Cese del nombramiento de Lindsay Duncan Gunn Darroch como director el 12 jul 2019

    1 páginasTM01
    X904L8ZT

    ¿Quiénes son los directivos de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    THORNTONS LAW LLP
    33 Yeaman Shore
    DD1 4BJ Dundee
    Whitehall House
    Scotland
    Secretario corporativo
    33 Yeaman Shore
    DD1 4BJ Dundee
    Whitehall House
    Scotland
    Tipo de identificaciónOtra entidad corporativa o firma
    Número de registroSO300381
    118364410001
    BROWN, Michael Andrew
    DD1 1NR Dundee
    17 South Tay Street
    Scotland
    Director
    DD1 1NR Dundee
    17 South Tay Street
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor257815200001
    COUSTON, Robert James Gair
    DD9 6EG Brechin
    31a St David Street
    Angus
    Scotland
    Director
    DD9 6EG Brechin
    31a St David Street
    Angus
    Scotland
    ScotlandScottishSolicitor105453410001
    DARROCH, Lindsay Duncan Gunn
    DD1 1QN Dundee
    2 West Marketgait
    Scotland
    Director
    DD1 1QN Dundee
    2 West Marketgait
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor257815310001
    DEWAR, Barry George
    DD11 1HL Arbroath
    78 High Street
    Director
    DD11 1HL Arbroath
    78 High Street
    ScotlandScottishSolicitor306098420001
    RYDER, Peter Gordon
    33 Yeaman Shore
    DD1 4BJ Dundee
    Whitehall House
    Scotland
    Director
    33 Yeaman Shore
    DD1 4BJ Dundee
    Whitehall House
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director316934900001
    TODD, Christopher John
    18 Greenmarket
    DD1 4QB Dundee
    Seabraes House
    Scotland
    Director
    18 Greenmarket
    DD1 4QB Dundee
    Seabraes House
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor306098610001
    GEDDES, David James Irving
    West High Street
    PH7 4PU Crieff
    25
    Perthshire
    Scotland
    Secretario
    West High Street
    PH7 4PU Crieff
    25
    Perthshire
    Scotland
    226387930001
    HODGE, Alison Margaret
    Calton Street
    PH13 9AJ Coupar Angus
    Union Bank Buildings
    Perthshire
    Scotland
    Secretario
    Calton Street
    PH13 9AJ Coupar Angus
    Union Bank Buildings
    Perthshire
    Scotland
    British182302830001
    REID, David William
    Greenhill 19 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    Secretario
    Greenhill 19 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    BritishSolicitor69128200001
    WEBSTER, Mark
    Clachbeag
    Tibbermore
    PH1 1QJ Perth
    Perthshire
    Secretario
    Clachbeag
    Tibbermore
    PH1 1QJ Perth
    Perthshire
    BritishSolicitor205040002
    ALLAN, Crawford William
    Barossa Place
    PH1 5JX Perth
    10
    Perthshire
    Scotland
    Director
    Barossa Place
    PH1 5JX Perth
    10
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritishSolicitor198314350001
    ANDERSON, Alastair Hamilton
    Viewmount
    Bellpark Park
    PH2 7AJ Perth
    Director
    Viewmount
    Bellpark Park
    PH2 7AJ Perth
    ScotlandScottishSolicitor31277380001
    BAILLIE, Alan John
    DD1 4BS Dundee
    37 Union Street
    Scotland
    Director
    DD1 4BS Dundee
    37 Union Street
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor105451350001
    BOLTON, Robert Buchanan Alexander
    Ruchilside
    Comrie
    PH6 2HU Crieff
    Perthshire
    Director
    Ruchilside
    Comrie
    PH6 2HU Crieff
    Perthshire
    ScotlandBritishSolicitor69128140001
    DARROCH, Lindsay Duncan Gunn
    DD1 4AR Dundee
    9 Whitehall Crescent
    Scotland
    Director
    DD1 4AR Dundee
    9 Whitehall Crescent
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor257815310001
    DAVIES, Alan Graham
    6 Kincarrathie Crescent
    PH2 7HH Perth
    Perth & Kinross
    Director
    6 Kincarrathie Crescent
    PH2 7HH Perth
    Perth & Kinross
    ScotlandBritishSolicitor88605190001
    FRENZ, Amanda Jane
    32 Muirfield
    PH1 1JJ Perth
    Perthshire
    Director
    32 Muirfield
    PH1 1JJ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishSolicitor83079900002
    GEDDES, David James Irving
    West High Street
    PH7 4AU Crieff
    25
    Director
    West High Street
    PH7 4AU Crieff
    25
    ScotlandBritishSolicitor85319610002
    GRAY, John Paterson
    Embden House
    Newton Street
    PH10 6SU Blairgowrie
    Perthshire
    Director
    Embden House
    Newton Street
    PH10 6SU Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritishSolicitor Writer To The Signet90036430001
    HART, John Miller
    The Studio
    High Street
    PH10 6ET Blairgowrie
    Perthshire
    Director
    The Studio
    High Street
    PH10 6ET Blairgowrie
    Perthshire
    BritishSolicitor69128280001
    HART, John Millar
    Gregorton
    Brucefield Road,Rosemount
    PH10 6LA Blairgowrie
    Perthshire
    Director
    Gregorton
    Brucefield Road,Rosemount
    PH10 6LA Blairgowrie
    Perthshire
    ScotlandBritishSolicitor69128280002
    HODGE, Alison Margaret
    Forneth
    PH8 0HE Dunkeld
    Greencrook
    Perthshire
    Director
    Forneth
    PH8 0HE Dunkeld
    Greencrook
    Perthshire
    ScotlandBritishSolicitor140261940001
    MACDUFF-DUNCAN, Robert Simon
    Charlotte Street
    PH1 5LL Perth
    8
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    Charlotte Street
    PH1 5LL Perth
    8
    Perthshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishSolicitor107806500002
    MARNOCH, Brian
    Hamilton Place
    PH1 1BB Perth
    14
    Director
    Hamilton Place
    PH1 1BB Perth
    14
    ScotlandBritishNone69128390003
    MARNOCH, Brian
    14 Hamilton Place
    PH1 1BB Perth
    Perthshire
    Director
    14 Hamilton Place
    PH1 1BB Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishSolciitor69128390003
    MCKAY, Hugh Derek
    DD1 4PA Dundee
    136-138 Nethergate
    Scotland
    Director
    DD1 4PA Dundee
    136-138 Nethergate
    Scotland
    ScotlandScottishSolicitor105451590001
    NAPIER, Alistair Graham
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    Director
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishSolicitor1025000001
    REID, David William
    Greenhill 19 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    Director
    Greenhill 19 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    United KingdomBritishSolicitor69128200001
    THOMSON, Kenneth William
    33 Yeaman Shore
    DD1 4BJ Dundee
    Whitehall House
    Scotland
    Director
    33 Yeaman Shore
    DD1 4BJ Dundee
    Whitehall House
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor105451200003
    WEBSTER, Mark
    Clachbeag
    Tibbermore
    PH1 1QJ Perth
    Perthshire
    Director
    Clachbeag
    Tibbermore
    PH1 1QJ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishSolicitor205040002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Tspc Holdings Limited
    Whitehall Crescent
    DD1 4AR Dundee
    11
    Scotland
    01 mar 2019
    Whitehall Crescent
    DD1 4AR Dundee
    11
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEdinburgh
    Número de registroSc279747
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Perthshire Solicitors Property Centre (Holdings) Ltd
    South St. Johns Place
    PH1 5SU Perth
    6
    Scotland
    06 abr 2016
    South St. Johns Place
    PH1 5SU Perth
    6
    Scotland
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Acts
    Lugar de registroEdinburgh
    Número de registroSc204627
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0