SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | SC204919 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
- Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (09100) / Explotación de minas y canteras
¿Dónde se encuentra SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP LIMITED | 14 ago 2002 | 14 ago 2002 |
| SPS-AFOS GROUP LIMITED | 16 jun 2000 | 16 jun 2000 |
| LEDGE 523 LIMITED | 13 mar 2000 | 13 mar 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden judicial Scheme of amalgamation | 8 páginas | OC | ||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Orden judicial Diss by c/order | 8 páginas | OC | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aprobación de re-registro | 1 páginas | FOA-RR | ||||||||||||||
Certificado de re-registro de Limitado a Ilimitado | 1 páginas | CERT3 | ||||||||||||||
Re-registro de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad privada de responsabilidad ilimitada | 2 páginas | RR05 | ||||||||||||||
Re-registro del Memorándum y Estatutos | 28 páginas | MAR | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Allan Walker como director el 18 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Giselle Evette Varn como director el 04 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Park como director el 31 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Colin David Beddall como director el 06 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como secretario el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Roman Higgins como director el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Giselle Evette Varn el 15 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL Scotland a 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ el 15 mar 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Giselle Evette Varn como director el 18 ene 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDDALL, Colin David, Mr. | Director | Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 287316070001 | |||||
| WALKER, Christopher Allan | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 299227560001 | |||||
| DROY MOORE, Pauline | Secretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 158496840002 | |||||||
| GORMLEY, Donald | Secretario | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | British | 105532790001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Secretario | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 270632900001 | |||||||
| SMOKER, Simon | Secretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203967810001 | |||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Secretario designado corporativo | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen | 900003330001 | |||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| ANDREWS, Jim | Director | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 163190540001 | |||||
| BROWN, Billy | Director | 3406 Oakland Drive Sugarland Texas 77479 Usa | American | 61863960001 | ||||||
| CARMICHAEL, Mark | Director | Douet De Rue St. Mary JE3 3EF Jersey Channel Islands | British | 41277830002 | ||||||
| COWAN, Raymond Andrew William | Director | Hillcrest Kincairn, Blairs AB12 5YQ Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 65217400001 | |||||
| ELLIS, Richard John Muir | Director | Burnside Kingsford Mews AB33 8HN Alford Aberdeenshire Scotland | British | 82194530001 | ||||||
| GIBB, William Ian Alexander | Director | St Eunans Road AB34 5HH Aboyne Kinnaird Aberdeenshire | United Kingdom | British | 103544230002 | |||||
| GORMLEY, Donald | Director | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 105532790001 | |||||
| HENDERSON, Jeremy Neil | Director | Tillyfour House Tough AB33 8DX Alford Aberdeenshire | British | 73430001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Director | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | England | British | 256940520001 | |||||
| HILL, Michael Colin | Director | 90 Desswood Place AB15 4DQ Aberdeen | United Kingdom | British | 96851120001 | |||||
| HOWLETT, Paul David | Director | 234 North Deeside Road Cults AB15 9PB Aberdeen | British | 55761030001 | ||||||
| JACK, Ian | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | British | 103412640012 | |||||
| JORDAN, John Robert | Director | 401 Vennard Avenue 70501 Lafayette Louisiana U.S.A. | American | 57399140001 | ||||||
| KIDD, Ryan Alexander | Director | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| KIRKPATRICK, John Finlay Alexander | Director | Stable End Hob Lane Barston B92 0JS Solihull W Midlands | British | 21187290002 | ||||||
| LAWS, Graeme Rodger | Director | 1 Mains Court AB32 6QZ Westhill Aberdeenshire | British | 52002630001 | ||||||
| MACKENZIE, Peter | Director | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | British | 114652960002 | ||||||
| MARSH, David | Director | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| PARK, Gary | Director | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 270424580001 | |||||
| PRESS, Michael Warner | Director | 2040 County Line Road 44040 Gates Mills 44040 Usa | United States | American | 105596780002 | |||||
| SMOKER, Simon | Director | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| VARN, Giselle Evette | Director | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 273564740002 | |||||
| WILLIAMS, Glynn Richard | Director | The Old Post Office Easton SO21 1EF Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 36481970003 | |||||
| DURANO LIMITED | Director designado corporativo | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen | 900003320001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-I Holdings (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Peregrine House Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SPECIALISED PETROLEUM SERVICES GROUP UNLIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creado el 24 may 2000 Entregado el 01 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floatingt charge over same. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 24 may 2000 Entregado el 01 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0