SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC206426 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
- Recolección, tratamiento y suministro de agua (36000) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
¿Dónde se encuentra SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Bridge 6 Buchanan Gate G33 6FB Stepps Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KELDA WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED | 09 abr 2010 | 09 abr 2010 |
| GRAMPIAN WASTE WATER SERVICES LIMITED | 05 sept 2003 | 05 sept 2003 |
| GRAMPIAN WASTEWATER SERVICES LIMITED | 12 abr 2000 | 12 abr 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2025 | 15 páginas | AA | ||
legacy | 80 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2024 | 16 páginas | AA | ||
legacy | 75 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||
Cambio de datos del director Simon Peter Wrigglesworth el 28 oct 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Darren May como director el 18 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Will como director el 18 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Peter William Farrer como director el 18 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Miss Susan Margaret Hill como secretario el 26 jun 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Ramsay George Robert Milne como secretario el 26 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Simon Peter Wrigglesworth el 19 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Castle House 6 Castle Drive Carnegie Campus Dunfermline Fife KY11 8GG Scotland a The Bridge 6 Buchanan Gate Stepps Glasgow G33 6FB el 01 jun 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 23 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILL, Susan Margaret | Secretario | 6 Buchanan Gate G33 6FB Stepps The Bridge Glasgow Scotland | 311152660001 | |||||||
| MAY, Darren | Director | 6 Buchanan Gate G33 6FB Stepps The Bridge Glasgow Scotland | Scotland | British | 321027720001 | |||||
| WRIGGLESWORTH, Simon Peter | Director | 6 Buchanan Gate G33 6FB Stepps The Bridge Glasgow Scotland | Scotland | British | 248374610002 | |||||
| DOWNES, Jane Claire | Secretario | 3 Oakleigh View Baildon BD17 5TP Shipley West Yorkshire | British | 48088850001 | ||||||
| HILL, Robert Christopher | Secretario | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | British | 72684940002 | ||||||
| MILNE, Ramsay George Robert | Secretario | 6 Buchanan Gate G33 6FB Stepps The Bridge Glasgow Scotland | 267244900001 | |||||||
| RUSSELL, Kimberley | Secretario | 6 Castle Drive Carnegie Campus KY11 8GG Dunfermline Castle House Fife Scotland | 254529810001 | |||||||
| WHITE, Angela Wendy Miriam | Secretario | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | 207136010001 | |||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 900003420001 | |||||||
| BIDDER, Adam John | Director | Kensington Court Lodge Moor S10 4NL Sheffield 4 South Yorkshire | England | British | 100999070001 | |||||
| CAWTHRA, Gavin Michael | Director | 24 Hall Drive Bramhope LS16 9JE Leeds | England | British | 109304380002 | |||||
| DIXON, Graham | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 72261110003 | |||||
| DIXON, Graham | Director | 26 Elm Grove Silsden BD20 0PU Keighley West Yorkshire | British | 72261110001 | ||||||
| DOCTOR, Graeme | Director | 45 Barlby Road North Kensington W10 6AW London | United Kingdom | British | 82839470002 | |||||
| DOHERTY, Pamela Jane | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 261608630001 | |||||
| FARRER, Peter William | Director | 6 Castle Drive Carnegie Campus KY11 8GG Dunfermline Castle House Fife Scotland | United Kingdom | British | 109691650001 | |||||
| HALL, Thomas | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 174916370003 | |||||
| HAYSOM, Charles Stewart | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89310950002 | |||||
| HAYSOM, Charles Stewart | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89310950002 | |||||
| HINTON, Andrew Peter | Director | Flat 57 Centaur House Great George Street LS1 3LA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 114646030001 | |||||
| KNIGHT, Ian Graham | Director | 92 Town Lane Thackley BD10 8PJ Bradford West Yorkshire | British | 36849090002 | ||||||
| MACPHERSON, Stephen | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 157116830001 | |||||
| MARRILL, Robert Brian | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 146789050001 | |||||
| PARKINSON, Timothy | Director | Back Lane Barnby NG24 2SD Newark The Old Stables Nottinghamshire | United Kingdom | British | 134680860001 | |||||
| PROCTER, Stephen John | Director | Grange Barn Ingham Lane, Bradshaw HX2 9PE Halifax West Yorkshire | British | 70065550001 | ||||||
| RAWSON, Ian Geoffrey | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 200975470001 | |||||
| ROACH, Andrew Lawson | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201212900001 | |||||
| WILL, Michael | Director | 6 Castle Drive Carnegie Campus KY11 8GG Dunfermline Castle House Fife Scotland | United Kingdom | British | 254539220001 | |||||
| WILLIAMSON, Susan Marilyn | Director | Stonefield Water Lane, Kirk Smeaton WF8 3LD Pontefract West Yorkshire | British | 110378440001 | ||||||
| WYNN, Paul David, Non-Exectuive Director | Director | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 180353010001 | |||||
| WYNN, Paul David, Non-Exectuive Director | Director | The Tythe Barn 3 Wordsworth Court, Water Hall Lane S36 8EQ Penistone | England | British | 180353010001 | |||||
| REYNARD NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 900011050001 | |||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 900003410001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SCOTTISH WATER SERVICES (GRAMPIAN) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Water Horizons Holdings Limited | 19 dic 2018 | 6 Castle Drive KY11 8GG Dunfermline Castle House Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Kelda Water Services Limited | 06 abr 2016 | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0