ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC207271 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Skypark Sp1 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SPH HOLDINGS LIMITED | 12 sept 2000 | 12 sept 2000 |
| DMWS 428 LIMITED | 18 may 2000 | 18 may 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 25 mar 2022
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 25 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 6th Floor, Skypark Sp1 8 Elliot Place Glasgow G3 8EP a Skypark Sp1 8 Elliot Place Glasgow G3 8EP el 12 ene 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart James Mitchell como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 may 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Marcus Noble como director el 18 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 10 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2020 au 30 sept 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cessation de Souter Kent Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 dic 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Notification de Dmgi Land & Property Europe Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 dic 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Jarvis como director el 18 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Calum Geoffrey Cusiter como director el 18 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Stephen Teague como secretario el 18 dic 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen John Stout como director el 18 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Daniel Johnston como director el 18 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAGUE, Matthew Stephen | Secretario | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark Sp1 Scotland | 265772530001 | |||||||||||
| BROWN, Simon James | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark Sp1 Scotland | England | British | 138828660001 | |||||||||
| JOHNSTON, Mark Daniel | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark Sp1 Scotland | United Kingdom | British | 158185090001 | |||||||||
| STOUT, Stephen John | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark Sp1 Scotland | United Kingdom | British | 154424780001 | |||||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian |
| 900000320001 | ||||||||||
| BENNETT, Arthur John | Director | 11a Langton Court Darras Hall NE20 9AT Ponteland Northumberland | British | 87246260001 | ||||||||||
| CUSITER, Calum Geoffrey | Director | George Street EH2 2LR Edinburgh 4th Floor, 68-70 City Of Edinburgh | Scotland | British | 147097150003 | |||||||||
| HARKNESS, Michael Elliot | Director | Antonine Road Dullatur G68 0FE Glasgow 18 Strathclyde | United Kingdom | British | 138646310001 | |||||||||
| JARVIS, Elizabeth | Director | 8 Elliot Street G3 8EP Glasgow The Skypark | Scotland | British | 102116070002 | |||||||||
| LEWANDOWSKI, Kenneth Macdonald Arthur | Director | 5 Allanwater Gardens Bridge Of Allan FK9 4DW Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 14010460001 | |||||||||
| MACFIE, Andrew James | Director | 9 Corrennie Gardens EH10 6DG Edinburgh | Scotland | British | 33487610001 | |||||||||
| MCCALL, Graham Kenneth | Director | Overhall House Sandford ML10 6PL Strathaven Glasgow | Scotland | British | 109694640001 | |||||||||
| MCWHINNIE, Stuart Alistair | Director | 10 Wishaw Low Road Cleland ML1 5QU Motherwell Lanarkshire | United Kingdom | British | 103461300001 | |||||||||
| MEGSON, Richard | Director | Westfield Redside Farm Steading EH39 5PE North Berwick East Lothian | British | 87248600001 | ||||||||||
| MITCHELL, Stuart James | Director | Elliot Place G3 8EP Glasgow 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 165110060002 | |||||||||
| NOBLE, Marcus | Director | Castle Farm House KA3 3DY Stewarton Ayrshire | United Kingdom | British | 75470330001 | |||||||||
| PARK, Ronald Gavin | Director | Manor House Hermand Estate EH55 8QZ West Calder West Lothian | Scotland | British | 41565040003 | |||||||||
| TOLLAND, Michael John | Director | 1a Corrour Road Newlands G43 2DT Glasgow | United Kingdom | British | 101219940002 | |||||||||
| VAN DEN HAAK, Maria Stefanie | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Skypark Uk | United Kingdom | British | 205276360001 | |||||||||
| WILLIAMS, Iestyn Milton | Director | Tainui Wey Road KT13 8HR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 141194370001 | |||||||||
| DM DIRECTOR LIMITED | Director designado corporativo | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900020020001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmgi Land & Property Europe Ltd | 18 dic 2019 | Eagle Way Sowton Industrial Estate EX2 7HY Exeter 5-7 Abbey Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Souter Kent Limited | 20 may 2016 | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ONESEARCH DIRECT HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 16 feb 2015 Entregado el 18 feb 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 14 sept 2000 Entregado el 29 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0