NIMBUS STYLE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNIMBUS STYLE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC208001
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NIMBUS STYLE LIMITED?

    • (2030) /

    ¿Dónde se encuentra NIMBUS STYLE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NIMBUS STYLE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LOGAN JOINERY LIMITED23 oct 200023 oct 2000
    MANOR KINGDOM LANDSCAPING LIMITED09 jun 200009 jun 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NIMBUS STYLE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NIMBUS STYLE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 06 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 jun 2011

    Estado de capital el 30 jun 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cese del nombramiento de David Gaffney como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 06 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robin Johnson como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Joanne Elizabeth Massey como secretario

    2 páginasAP03

    Cambio de datos del secretario Robin Simon Johnson el 24 nov 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Dominic Joseph Lavelle el 06 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director David Gaffney el 13 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    31 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    21 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    33 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Group specific conflicts 01/09/2009
    RES13

    legacy

    10 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de NIMBUS STYLE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808810001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MCKENZIE, Iain Malcolm Robert
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    Midlothian
    British68440650002
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Secretario
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Secretario
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    British67033440002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD.
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    900018690001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    INGRAM, David Colin
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    Director
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    British109149390001
    KEENAN, Grant Patrick
    36 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    Director
    36 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    ScotlandBritish111271350001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LOGAN, Robert
    Glenhaven
    6b Dryside Road
    KY13 9ND Glen Lomond
    Kinross
    Director
    Glenhaven
    6b Dryside Road
    KY13 9ND Glen Lomond
    Kinross
    British73081120001
    MCKENZIE, Iain Malcolm Robert
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    Midlothian
    Director
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    Midlothian
    British68440650002
    MEECHAN, Ian Vincent
    2 Montgomery Street
    KY13 8DU Kinross
    Fife
    Director
    2 Montgomery Street
    KY13 8DU Kinross
    Fife
    British70530050001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Director
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritish78545300002
    O'CALLAGHAN, Sean James
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    Director
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    British101412420001
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Director
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritish142078700006
    SCOTT, David
    66 Castle Street
    TD11 3BE Duns
    Berwickshire
    Director
    66 Castle Street
    TD11 3BE Duns
    Berwickshire
    British127153850001
    SNEDDON, Lisa Marion
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    Director
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    British101413820001
    PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD.
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Director designado corporativo
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    900018690001
    PETER TRAINER COMPANY SERVICES LTD.
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Director designado corporativo
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    900018680001

    ¿Tiene NIMBUS STYLE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 14 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 08 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2009Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 15 feb 2001
    Entregado el 21 feb 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 feb 2001Registro de un cargo (410)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0