NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED

NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC210905
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TM 1163 LIMITED12 sept 200012 sept 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    7 páginas4.26(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA a Saltire Court, 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 23 abr 2015

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 16 abr 2015

    LRESSP

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approve debts 02/04/2015
    RES13

    Estado de capital el 02 abr 2015

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Any right of entitlement waived and notwithstanding any provisions contained in the articles which may prohibit, limit or restrict the capital reduction and any reserve arising from capital reduction treated as realised profit and possible conflict of interest 01/04/2015
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 12 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 oct 2014

    Estado de capital el 10 oct 2014

    • Capital: GBP 1,714,286
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Hamish Forbes como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Jenny Nancy Loncaster como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Malcolm Herbert Lofts como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 12 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 oct 2013

    Estado de capital el 02 oct 2013

    • Capital: GBP 1,714,286
    SH01

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Stephen Leadbeater como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Hamish Drummond Forbes como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Britton como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    8 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approval of various tabled restructuring documents, directors are authorised to execute & deliver said docs, directors to avoid conflict of interest 20/09/2012
    RES13

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2012 au 30 sept 2012

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 12 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    8 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approval of various docs, auth of directors & sec to execute & deliver documents, directors conflict of interest 11/06/2012
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Town Hall Square
    PO BOX 16
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    N E Lincolnshire
    Great Britain
    Secretario designado corporativo
    Town Hall Square
    PO BOX 16
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    N E Lincolnshire
    Great Britain
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02249348
    900013350001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court, 20
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court, 20
    EnglandBritishDirector177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court, 20
    Director
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court, 20
    EnglandBritishFinance Director185293570001
    GAULT, Sandra
    25 Pitblae Gardens
    AB43 7BH Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Secretario
    25 Pitblae Gardens
    AB43 7BH Fraserburgh
    Aberdeenshire
    British61174690002
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    ANDERSON, Ian Scott
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritishMusician681230002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Director
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector127835580001
    FORBES, Hamish Drummond
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Director
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandBritishChartered Accountant66295550001
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Director
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanishDirector127032620001
    HAZELDEAN, James William
    29/5 Inverleith Place
    EH3 5QD Edinburgh
    Director
    29/5 Inverleith Place
    EH3 5QD Edinburgh
    BritishCompany Director10359650003
    LAINE, Jean Claude Robert
    Chemin De Montan
    Mont Brun-Lauragais 31450
    France
    Director
    Chemin De Montan
    Mont Brun-Lauragais 31450
    France
    FrenchCompany Director77572690001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Director
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector84487230001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Director
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector2785890001
    PORTEOUS, Ronald
    Coirseunan Lodge
    Whitecairns
    AB23 8UN Aberdeen
    Director
    Coirseunan Lodge
    Whitecairns
    AB23 8UN Aberdeen
    BritishCompany Director42171410001
    WRIGHT, Robin James Morrison
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    Director
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishManaging Director71513490001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Director designado corporativo
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Director designado corporativo
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    ¿Tiene NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 oct 2008
    Entregado el 05 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 05 nov 2008Registro de un cargo (410)
    • 19 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 mar 2007
    Entregado el 31 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent
    Transacciones
    • 31 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 28 oct 2008
    Debenture
    Creado el 16 mar 2006
    Entregado el 29 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 29 mar 2006Registro de un cargo (410)
    • 28 oct 2008
    • 28 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 12 dic 2005
    Entregado el 20 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 20 dic 2005Registro de un cargo (410)
    • 15 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 30 jun 2004
    Entregado el 10 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 10 jul 2004Registro de un cargo (410)
    • 28 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Debenture
    Creado el 20 dic 2000
    Entregado el 04 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 ene 2001Registro de un cargo (410)
    • 23 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 20 dic 2000
    Entregado el 03 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 ene 2001Registro de un cargo (410)
    • 05 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene NEPTUNE HOLDINGS UK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 abr 2016Fecha prevista de disolución
    16 abr 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0