BIFFA ARGYLL & BUTE LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | BIFFA ARGYLL & BUTE LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC211187 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Dirección de la sede social | 101 Clydesmill Drive Clydesmill Industrial Estate G32 8RG Cambuslang Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RENEWI ARGYLL & BUTE LIMITED | 09 oct 2017 | 09 oct 2017 |
| SHANKS ARGYLL & BUTE LIMITED | 14 nov 2000 | 14 nov 2000 |
| LOTHIAN FIFTY (689) LIMITED | 20 sept 2000 | 20 sept 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Marc Anthony Angell como director el 13 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessation de Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 oct 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Modification des détails de Renewi Argyll & Bute Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 oct 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed renewi argyll & bute LIMITED\certificate issued on 17/10/24 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Ms Sarah Parsons como secretario el 10 oct 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Robert Mason Topham como director el 10 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Pieter James Murray como secretario el 10 oct 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF a 101 Clydesmill Drive Clydesmill Industrial Estate Cambuslang Glasgow G32 8RG el 15 oct 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Dominic Pieter James Murray como secretario el 01 jun 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Bernard Griffin-Smith como secretario el 31 may 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Alistair Daniel Brookes el 23 ene 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Craig Owen el 23 ene 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Philip Bernard Griffin-Smith el 23 ene 2023 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roy Kyle como director el 08 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Craig Owen como director el 09 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSONS, Sarah | Secretario | Clydesmill Drive Clydesmill Industrial Estate G32 8RG Cambuslang 101 Glasgow Scotland | 328258210001 | |||||||
| ANGELL, Marc Anthony | Director | Clydesmill Drive Clydesmill Industrial Estate G32 8RG Cambuslang 101 Glasgow Scotland | England | British | 328950260001 | |||||
| BROOKES, Alistair Daniel | Director | Wavendon Business Park Ortensia Drive, Wavendon MK17 8LX Milton Keynes Enigma Buckinghamshire England | England | British | 196460830001 | |||||
| OWEN, Craig | Director | Wavendon Business Park Ortensia Drive, Wavendon MK17 8LX Milton Keynes Enigma Buckinghamshire England | England | British | 303577830001 | |||||
| TOPHAM, Michael Robert Mason | Director | Clydesmill Drive Clydesmill Industrial Estate G32 8RG Cambuslang 101 Glasgow Scotland | England | British | 181930560001 | |||||
| CANNON, Sara Philipa | Secretario | 15 Weathercock Lane MK17 8NP Woburn Sands Buckinghamshire | British | 223577480001 | ||||||
| GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard | Secretario | Wavendon Business Park, Ortensia Drive, Wavendon MK17 8LX Milton Keynes Enigma Buckinghamshire England | British | 130189950001 | ||||||
| LEWIS, Joanne Elizabeth Taunton | Secretario | 37 Primrose Close Flitwick MK45 1PL Bedford Beds | British | 73579280002 | ||||||
| MURRAY, Dominic Pieter James | Secretario | Wavendon Business Park, Ortensia Drive, Wavendon MK17 8LX Milton Keynes Enigma Buckinghamshire England | 309862450001 | |||||||
| BURNESS | Secretario designado corporativo | 242 West George Street G2 4QY Glasgow | 900020360001 | |||||||
| AITCHISON, Nigel Ian | Director | Willow House 29 High Street Silverstone NN12 8US Towcester Northamptonshire | England | British | 88285320001 | |||||
| AVERILL, Michael Charles Edward | Director | Little Meadow Upton Road Dinton HP17 8UQ Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24913560002 | |||||
| BAYLEY, Elizabeth Mary | Director | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 177180220001 | |||||
| CARTWRIGHT, Robert Ian | Director | c/o Phil Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | England | British | 73331440001 | |||||
| CARTWRIGHT, Robert Ian | Director | 10 Lydiard Close HP21 9XU Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 73331440001 | |||||
| CATLING, Nigel Frank | Director | c/o Phil Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | England | British | 196450880001 | |||||
| CLARKE, Michael James | Director | Derwen House Kibblestone Road ST15 8UJ Stone Staffordshire | England | British | 154591790014 | |||||
| COWAN, Mark Alfred | Director | c/o Mr Philip Griffin-Smith, Renewi Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | Scotland | British | 252744920001 | |||||
| DOWNES, David John | Director | Holden Brook New Barn Lane RH5 5PF Ockley Surrey | United Kingdom | British | 37289200002 | |||||
| EGLINTON, Peter Damian | Director | c/o C/O Mr Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 137660810001 | |||||
| GOODFELLOW, Ian Frederick | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 28725450004 | |||||
| HOLMES, Paul Frederek | Director | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House United Kingdom | England | British | 149066400001 | |||||
| KYLE, Roy | Director | Auckland Park, Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 277257900001 | |||||
| LUCAS, Richard Dexter | Director | Merkland House Buccleuch Place DG10 9AN Moffat Dumfriesshire | British | 62776780002 | ||||||
| MARTIN, Brian James | Director | 59 Lauderdale Gardens Hyndland G12 9QU Glasgow | British | 87328890001 | ||||||
| MCVICKER, Alan William Fullerton | Director | Ballykeel East Tulchan Steadings PH1 3SG Glenalmond Perthshire | British | 142373580001 | ||||||
| MEREDITH, James Robert | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West 900 Northamptonshire | British | 29339860005 | ||||||
| MULLIGAN, David Kevin | Director | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 74215210003 | |||||
| PATRICKSON, Alan Duncan | Director | 32 Redclyffe Gardens G84 9JJ Helensburgh | British | 89727740001 | ||||||
| RAWLING, Mark Andrew | Director | c/o Mr Philip Griffin-Smith, Renewi Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 252748150001 | |||||
| RAY, Stephen Leslie | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 169241640001 | |||||
| RICHFORD, Adam Nathaniel | Director | c/o Mr Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 126705600001 | |||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 139588670003 | |||||
| SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162166120001 | |||||
| STEVENSON, Robin Bruce | Director | Auckland Park, Mount Farm Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158777870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BIFFA ARGYLL & BUTE LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | The Mound EH1 1YZ Edinburgh The Mound Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Biffa Argyll & Bute Holdings Limited | 06 abr 2016 | Clydesmill Drive Clydesmill Industrial Estate G32 8RG Glasgow 101 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0