GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC212975 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLADEDALE (NEWCASTLE) LIMITED | 25 ene 2007 | 25 ene 2007 |
| BETT HOMES (NORTH EAST) LIMITED | 19 feb 2001 | 19 feb 2001 |
| MORBISH 11 LIMITED | 20 nov 2000 | 20 nov 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa | 1 páginas | DS02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Jon William Mortimore como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | 147809120001 | |||||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MASON, Eddie Roy | Secretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
| MORBISH SECRETARY LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900020930001 | |||||||
| ALDER, Edmund | Director | Beech Tree Barn 4 Laker Hall NE43 7UZ Stocksfield Northumberland | British | 121966280002 | ||||||
| ANDERSON, Alexander | Director | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||
| ANDERSON, Don | Director | 35 King George Road NE34 0SR South Shields Tyne & Wear | British | 88101730001 | ||||||
| BARLOW, David St John | Director | Inglewood Slaley NE47 0AA Hexham | British | 40287360005 | ||||||
| BECKWITH, Nicholas Mark | Director | 12 Village Farm Walbottle NE15 8JW Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | 110767010001 | ||||||
| BETT, Iain Charles Rattray | Director | Kingennie House Kingennie DD5 3RD Dundee | Scotland | British | 95179330001 | |||||
| BURNETT, Andrew | Director | 170 Forest Gate NE12 9EN Newcastle Tyne & Wear | British | 102667770001 | ||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Director | 50 Warlington Road CR7 7DE Thornton Heath Surrey | British | 75350600001 | ||||||
| HANNA, Ronald George | Director | 34 Primrose Bank Road EH5 3JF Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 8506940001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LAW, Ronald Douglas | Director | 20 St.Johns Road CH4 7AL Chester Cheshire | British | 75561960001 | ||||||
| LINCOLN, Frank James | Director | 10 Norham Road Newton Hall DH1 5NU Durham County Durham | United Kingdom | British | 105239650001 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| TALLENTIRE, Ian | Director | 19 Neville Close Evenwood DL14 9SQ Bishop Auckland Durham | United Kingdom | English | 87650740001 | |||||
| WHITWOOD, David | Director | 3 Aspley Close Silksworth SR3 2ES Sunderland Tyne And Wear | British | 110726120001 | ||||||
| WILLIAMS, Geoffrey Edward | Director | 6 Oakfield North NE40 3AD Ryton Tyne & Wear | British | 12510660001 | ||||||
| WORSFOLD, Leonard Edwin | Director | 14 Sunniside Lane Claedon SR6 7XB Sunderland | Great Britain | British | 48232700001 | |||||
| MORBISH DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900020920001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant Homes Group Limited | 06 abr 2016 | Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House 6 And 9 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GLADEDALE (NORTH EAST ENGLAND) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 14 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 08 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 may 2003 Entregado el 03 jun 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0