SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED

SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC213517
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    • Actividades de trabajo social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas (88100) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SIGHT ACTION15 ene 200915 ene 2009
    VISUAL IMPAIRMENT SERVICES HIGHLAND06 dic 200006 dic 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2024
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2024
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 feb 2025
    Próxima declaración de confirmación vence17 feb 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 feb 2024
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Domicilio social registrado cambiado de Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ Scotland a Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row Aberdeen AB10 1SA el 10 abr 2024

    3 páginasAD01

    Orden judicial en una liquidación (y adjunto de la orden judicial)

    4 páginasWU01(Scot)

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Maureen Mary Macmillan como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Rob Polson como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David King como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Emily Elizabeth Mary Gray como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Murray Cochrane como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023

    23 páginasAA

    Nombramiento de Mr Scott Alan Murray como director el 21 nov 2023

    2 páginasAP01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed sight action\certificate issued on 01/09/23
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name01 sept 2023

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 24 jul 2023

    RES15

    Nombramiento de Miss Lynsey Daniel como secretario el 01 jul 2023

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    26 páginasAA

    Cese del nombramiento de Sandra May Elizabeth Ross como secretario el 08 nov 2022

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Beechwood House 69 - 71 Old Perth Road Raigmore Inverness Highland Region IV2 3JH a Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ el 15 ago 2022

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Edward Murray Cochrane como director el 01 feb 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Grant como director el 19 ago 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan Peter Fowler como director el 11 may 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher Grant como director el 09 mar 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2020

    22 páginasAA

    Nombramiento de Mr David King como director el 10 nov 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DANIEL, Lynsey
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Secretario
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    310993760001
    MACLEAN, Angela Margaret
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Director
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    ScotlandBritishHighland Councillor93204940001
    MURRAY, Scott Alan
    Chattan Gardens
    IV12 4QP Nairn
    Dunevan
    Scotland
    Director
    Chattan Gardens
    IV12 4QP Nairn
    Dunevan
    Scotland
    United KingdomBritishCeo173911240003
    ROWANTREE, Robert Ian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Director
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    United KingdomBritishLand Manager57180660001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Secretario
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    British57440560001
    MCLENAN, Sarah Louise
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Secretario
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    261749260001
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    Secretario
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    BritishSolicitor73180870001
    ROBERTSON, Michael Andrew
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Secretario
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    169920830001
    ROSS, Sandra May Elizabeth
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Secretario
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    267631590001
    ROSS, Sandra
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Secretario
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    174219790001
    SPITTAL, Felix Thomas
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Secretario
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    164999560001
    BAINBRIDGE, Raymond
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Director
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    ScotlandBritishRitired157900700001
    BOYLE, Nicholas Michael
    Windyhills Achlaschoille Farmhouse
    Farr
    IV2 6XG Inverness
    Invernesshire
    Director
    Windyhills Achlaschoille Farmhouse
    Farr
    IV2 6XG Inverness
    Invernesshire
    ScotlandBritishCompany Director116796780001
    CAMPBELL, Hugh Macarthur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    United KingdomBritishOptometrist113911180001
    CHATTERTON, Jean, Dr
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritishRetired199763500001
    COCHRANE, Edward Murray
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Director
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishRetired162624860001
    CULLINGHAM, Terence James
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    Director
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    ScotlandBritishRetired97749010002
    CUMMING, Christina
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    Director
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    BritishHighland Cllr121428950001
    FOWLER, Alan Peter
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    ScotlandBritishChief Officer, Signpost258273310001
    FRASER, James Robert Simpson
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    United KingdomBritishRetired197996780001
    GRANT, Christopher
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    ScotlandBritishCommunity Relationship Officer279588350001
    GRAY, Emily Elizabeth Mary
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Director
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishUnemployed218607290003
    HO-YEN, Darrel Orlando, Doctor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritishRetired183119510001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Director
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Scotland,UkBritishHealth Board Manager (Retired)57440560001
    JOHN, David Phillip
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Director
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritishRetired166909770001
    KING, David
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Director
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director254314190001
    MACDONALD, Margaret
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    Director
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    ScotlandBritishNone97901380001
    MACKINNON, Iain
    Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Director
    Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandScottishPostal Worker179390360001
    MACLEAN, Elizabeth Anne
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    Director
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritishRetired27235670001
    MACMILLAN, Maureen Mary
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Director
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishRetired26305820003
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    Director
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishSolicitor73180870001
    MOORE, Raymond John Kentigern
    8 Abertarff Road
    IV2 3NW Inverness
    Inverness Shire
    Director
    8 Abertarff Road
    IV2 3NW Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishRetired90612420001
    PATERSON, David Weatherston
    Drumnadrochit
    Drumnadrochit
    IV63 6TZ Inverness
    Dalgregaig House
    United Kingdom
    Director
    Drumnadrochit
    Drumnadrochit
    IV63 6TZ Inverness
    Dalgregaig House
    United Kingdom
    ScotlandBritishRetired150263780001
    POLSON, Rob
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Director
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishLibrarian, Health Sciences, Inverness258273400001
    ROBERTSON, Michael Andrew
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Director
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    ScotlandScottishMinister Of Religion169250390001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 dic 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 mar 2024Fecha de la petición
    28 mar 2024Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Callum Angus Carmichael
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Profesional
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Graham David Smith
    Suite B, 4th Floor Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Profesional
    Suite B, 4th Floor Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0