SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Liquidación |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | SC213517 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
- Actividades de trabajo social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas (88100) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Dirección de la sede social | Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row AB10 1SA Aberdeen |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SIGHT ACTION | 15 ene 2009 | 15 ene 2009 |
VISUAL IMPAIRMENT SERVICES HIGHLAND | 06 dic 2000 | 06 dic 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2024 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 feb 2025 |
Próxima declaración de confirmación vence | 17 feb 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 feb 2024 |
Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ Scotland a Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row Aberdeen AB10 1SA el 10 abr 2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Orden judicial en una liquidación (y adjunto de la orden judicial) | 4 páginas | WU01(Scot) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Maureen Mary Macmillan como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rob Polson como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David King como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Emily Elizabeth Mary Gray como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Murray Cochrane como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Scott Alan Murray como director el 21 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed sight action\certificate issued on 01/09/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Miss Lynsey Daniel como secretario el 01 jul 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra May Elizabeth Ross como secretario el 08 nov 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Beechwood House 69 - 71 Old Perth Road Raigmore Inverness Highland Region IV2 3JH a Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ el 15 ago 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Edward Murray Cochrane como director el 01 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Grant como director el 19 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Peter Fowler como director el 11 may 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Grant como director el 09 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2020 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr David King como director el 10 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL, Lynsey | Secretario | Union Row AB10 1SA Aberdeen Suite B, 4th Floor, Meridian | 310993760001 | |||||||
MACLEAN, Angela Margaret | Director | Union Row AB10 1SA Aberdeen Suite B, 4th Floor, Meridian | Scotland | British | Highland Councillor | 93204940001 | ||||
MURRAY, Scott Alan | Director | Chattan Gardens IV12 4QP Nairn Dunevan Scotland | United Kingdom | British | Ceo | 173911240003 | ||||
ROWANTREE, Robert Ian | Director | Union Row AB10 1SA Aberdeen Suite B, 4th Floor, Meridian | United Kingdom | British | Land Manager | 57180660001 | ||||
JACK, Malcolm Lyall | Secretario | Lismore Tower Brae Westhill IV1 2BW Inverness | British | 57440560001 | ||||||
MCLENAN, Sarah Louise | Secretario | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region | 261749260001 | |||||||
MERCHANT, Joan Isobel Sinclair | Secretario | 3 Crown Circus IV2 3NH Inverness Inverness Shire | British | Solicitor | 73180870001 | |||||
ROBERTSON, Michael Andrew | Secretario | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | 169920830001 | |||||||
ROSS, Sandra May Elizabeth | Secretario | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | 267631590001 | |||||||
ROSS, Sandra | Secretario | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | 174219790001 | |||||||
SPITTAL, Felix Thomas | Secretario | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | 164999560001 | |||||||
BAINBRIDGE, Raymond | Director | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | Scotland | British | Ritired | 157900700001 | ||||
BOYLE, Nicholas Michael | Director | Windyhills Achlaschoille Farmhouse Farr IV2 6XG Inverness Invernesshire | Scotland | British | Company Director | 116796780001 | ||||
CAMPBELL, Hugh Macarthur | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | United Kingdom | British | Optometrist | 113911180001 | ||||
CHATTERTON, Jean, Dr | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | British | Retired | 199763500001 | ||||
COCHRANE, Edward Murray | Director | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Retired | 162624860001 | ||||
CULLINGHAM, Terence James | Director | Churchill Drive IV15 9RD Dingwall 11 Ross-Shire | Scotland | British | Retired | 97749010002 | ||||
CUMMING, Christina | Director | 72 Kenneth Street IV3 5PZ Inverness Inverness Shire | British | Highland Cllr | 121428950001 | |||||
FOWLER, Alan Peter | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region | Scotland | British | Chief Officer, Signpost | 258273310001 | ||||
FRASER, James Robert Simpson | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | United Kingdom | British | Retired | 197996780001 | ||||
GRANT, Christopher | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region | Scotland | British | Community Relationship Officer | 279588350001 | ||||
GRAY, Emily Elizabeth Mary | Director | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Unemployed | 218607290003 | ||||
HO-YEN, Darrel Orlando, Doctor | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | British | Retired | 183119510001 | ||||
JACK, Malcolm Lyall | Director | Lismore Tower Brae Westhill IV1 2BW Inverness | Scotland,Uk | British | Health Board Manager (Retired) | 57440560001 | ||||
JOHN, David Phillip | Director | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | British | Retired | 166909770001 | ||||
KING, David | Director | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Managing Director | 254314190001 | ||||
MACDONALD, Margaret | Director | 13 Balconie Park Evanton IV16 9XD Dingwall Ross Shire | Scotland | British | None | 97901380001 | ||||
MACKINNON, Iain | Director | Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | Scottish | Postal Worker | 179390360001 | ||||
MACLEAN, Elizabeth Anne | Director | Grianan Woodside Avenue PH26 3JR Grantown On Spey Morayshire | Scotland | British | Retired | 27235670001 | ||||
MACMILLAN, Maureen Mary | Director | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Retired | 26305820003 | ||||
MERCHANT, Joan Isobel Sinclair | Director | 3 Crown Circus IV2 3NH Inverness Inverness Shire | Scotland | British | Solicitor | 73180870001 | ||||
MOORE, Raymond John Kentigern | Director | 8 Abertarff Road IV2 3NW Inverness Inverness Shire | Scotland | British | Retired | 90612420001 | ||||
PATERSON, David Weatherston | Director | Drumnadrochit Drumnadrochit IV63 6TZ Inverness Dalgregaig House United Kingdom | Scotland | British | Retired | 150263780001 | ||||
POLSON, Rob | Director | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Librarian, Health Sciences, Inverness | 258273400001 | ||||
ROBERTSON, Michael Andrew | Director | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | Scotland | Scottish | Minister Of Religion | 169250390001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
06 dic 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación forzosa |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0