MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED

MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC213944
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ANDSTRAT (NO.124) LIMITED19 dic 200019 dic 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Mr Neil Fitzsimmons el 01 nov 2011

    2 páginasCH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 21 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 feb 2012

    Estado de capital el 06 feb 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approve transfer of property 14/12/2011
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 dic 2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    3 páginasMG02s

    Cambio de datos del director Norman Yardley el 08 jul 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share purchase 28/01/2011
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 21 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Norman Yardley como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Gaffney como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 21 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robin Johnson como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Joanne Elizabeth Massey como secretario

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808870001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector153904770001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Secretario
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    BritishDirector78545300002
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Secretario
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    British67033440002
    ANDERSON STRATHERN WS
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    900020500001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishHead Of Joint Ventures122926460001
    BROWN, Andrew
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    Director
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandScottishTechnical Director91209410001
    BROWN, Simon Thomas David
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor118942920001
    CHARITY, Sheena
    18 Long Craig Walk
    KY1 1SJ Kirkcaldy
    Fife
    Director
    18 Long Craig Walk
    KY1 1SJ Kirkcaldy
    Fife
    BritishDirector66765420001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    KERR, John Neilson
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor65694070001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Director
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    BritishCommercial Director110231420001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Director
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant94163020001
    MACLEOD, Angus Iain
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    Director
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    ScotlandBritishDirector57667380001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Director
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    BritishDirector Of If73738070001
    MILLER, Simon Edward Callum
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    Director
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    ScotlandBritishCompany Director176036600001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Director
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritishAccountant78545300002
    O'CALLAGHAN, Sean James
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    Director
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    BritishManaging Director Designate101412420001
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Director
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishDirector67033440002
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Director
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritishChartered Surveyor142078700006
    SNEDDON, Lisa Marion
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    Director
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    BritishSales Director101413820001

    ¿Tiene MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 14 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 08 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2009Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 13 abr 2004
    Entregado el 21 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    37.8 hectares at dollarbeg, dollar CLK8727.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 abr 2004Registro de un cargo (410)
    • 29 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 05 abr 2004
    Entregado el 16 abr 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 abr 2004Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 03 oct 2002
    Entregado el 14 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The additional sum referred to in missives dated 26 june and 23 august 2002
    Breve descripción
    Three areas of ground at dollarbeg, dollar, clackmannanshire (title numbers CLK5768, CLK3368 & CLK7647).
    Personas con derecho
    • Dollarbeg Estates Limited and Others
    Transacciones
    • 14 oct 2002Registro de un cargo (410)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Standard security
    Creado el 05 mar 2001
    Entregado el 12 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    494 ferry road, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 mar 2001Registro de un cargo (410)
    • 03 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 05 mar 2001
    Entregado el 12 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    8 fox covert avenue, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 mar 2001Registro de un cargo (410)
    • 03 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 28 feb 2001
    Entregado el 02 mar 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due under the senior facility agreement dated 28 february 2001
    Breve descripción
    The whole of the property including uncalled capital execept the excepted properties.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 mar 2001Registro de un cargo (410)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0