SOCIAL FIRMS UK

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOCIAL FIRMS UK
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC214915
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOCIAL FIRMS UK?

    • Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SOCIAL FIRMS UK?

    Dirección de la sede social
    43 Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOCIAL FIRMS UK?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOCIAL FIRMS UK - EMPLOYMENT SUPPORT UNIT19 ene 200119 ene 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOCIAL FIRMS UK?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SOCIAL FIRMS UK?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOCIAL FIRMS UK?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 1

    3 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE a 43 Bath Street Glasgow G2 1HW el 19 mar 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2015, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Thomas John Storey como director el 22 jun 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2014

    25 páginasAA

    Nombramiento de Mr David Anthony Honeybill como director el 28 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Pepin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kathryn Gilbert como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Hebditch como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Geoffrey Cox como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Bates como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2014, aucune liste de membres fournie

    9 páginasAR01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Aplin como director

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2013

    28 páginasAA

    Cese del nombramiento de Derek Mcclure como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Dr Kenneth Murdoch Knox Macdonald como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2013, aucune liste de membres fournie

    9 páginasAR01

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04

    Nombramiento de Mr David Gareth Aplin como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SOCIAL FIRMS UK?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RIGBY, Pauline Michele
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    Secretario
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    164939610001
    CHARLES, John, Dr
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    Director
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    EnglandBritishManager122255720001
    FAIRBAIRN, Robert Redvers
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    Director
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    United KingdomBritishManager164630050001
    HARRIS, Adrian John
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    Director
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    EnglandBritishManager122225930001
    HONEYBILL, David Anthony
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    Director
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Director185436600001
    LEONARD, Sandra
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United Kingdom
    WalesBritishBusiness Development Officer119694020001
    MACDONALD, Kenneth Murdoch Knox
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    Director
    Bath Street
    G2 1HW Glasgow
    43
    Scotland
    ScotlandScottishAssistant Commissioner104312920001
    REYNOLDS, Sally Caroline
    New Causeway
    RH2 7PP Reigate
    87
    Surrey
    Secretario
    New Causeway
    RH2 7PP Reigate
    87
    Surrey
    British82810650002
    ANDERSON, Karen Leigh
    31 Brookside
    Houghton
    PE28 2BT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    31 Brookside
    Houghton
    PE28 2BT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishConsultant94101180002
    APLIN, David Gareth, Rev.
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishOperations Director25549290001
    ASHTON, Mark William
    23 March Lane
    Cherry Hinton
    CB1 3LG Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    23 March Lane
    Cherry Hinton
    CB1 3LG Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishManager100484160001
    AXTEN, Tracy Ann
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    United KingdomBritishManager108518180002
    BATES, Ian Walter
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishSupport Services Director115013130001
    BATES, Keith James
    125 Thingwall Park
    BS16 2DB Bristol
    Director
    125 Thingwall Park
    BS16 2DB Bristol
    United KingdomBritishManager59798490002
    BATES, Keith James
    125 Thingwall Park
    BS16 2DB Bristol
    Director
    125 Thingwall Park
    BS16 2DB Bristol
    United KingdomBritishDevelopment Consltant59798490002
    BENNETT, John Anthony
    78 Uplands Crescent
    Llandough
    CF64 2PS Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Director
    78 Uplands Crescent
    Llandough
    CF64 2PS Penarth
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishCompany Director50791580002
    BINNALL, Richard Peter
    15 River Mead
    CM7 9AX Braintree
    Essex
    Director
    15 River Mead
    CM7 9AX Braintree
    Essex
    EnglandBritishConsultant69445590001
    BIRD, Alexander Maxwell
    95 Ninian Road
    Roath Park
    CF23 5EQ Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    95 Ninian Road
    Roath Park
    CF23 5EQ Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCharity Director13361130001
    BOREHAM, Stuart Charles
    7 Blenheim Way
    GL56 9NA Moreton-In-Marsh
    Gloucestershire
    Director
    7 Blenheim Way
    GL56 9NA Moreton-In-Marsh
    Gloucestershire
    BritishCompany Director108294100001
    CORNFIELD, Alan Trevor
    17 Melverley Grove
    Great Barr
    B44 8LA Birmingham
    West Midlands
    Director
    17 Melverley Grove
    Great Barr
    B44 8LA Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Manager76657710001
    COX, Andrew Nigel
    113 Dykelands Road
    SR6 8DX Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    113 Dykelands Road
    SR6 8DX Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector (Title Only)75369530001
    COX, Geoffrey Alan
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    FranceBritishSelf-Employed125835500003
    CRAWLEY, Sarah Ann
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant185749730001
    CRITCHLEY, Kathryn Helen
    Upper Flat
    Hallyburton Mains
    PH13 9JR Blairgowrie
    Perthshire
    Director
    Upper Flat
    Hallyburton Mains
    PH13 9JR Blairgowrie
    Perthshire
    BritishChe Social Firms Scotland94485140001
    DREYER, Petra
    Farmhouse
    St Clements, Foxhall Road
    IP3 8LS Ipswich
    Director
    Farmhouse
    St Clements, Foxhall Road
    IP3 8LS Ipswich
    GermanConsultant98585060001
    DURIE, Sheila
    29 Haldane Avenue
    EH41 3PG Haddington
    East Lothian
    Director
    29 Haldane Avenue
    EH41 3PG Haddington
    East Lothian
    ScotlandBritishManager1389780002
    GILBERT, Kathryn Mary
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    EnglandBritishAssistant Chief Officer175471850001
    GRAHAM, Cecil William Lavery
    97 Orby Drive
    BT5 6AG Belfast
    Director
    97 Orby Drive
    BT5 6AG Belfast
    BritishCheif Executive33399350001
    GRAHAM, Pauline
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United Kingdom
    ScotlandBritishCeo132023760001
    GROVE, Robert Norman, Dr
    41 St Pancras Court
    N2 9AE London
    Director
    41 St Pancras Court
    N2 9AE London
    United KingdomBritishConsultant/Researcher146754080001
    HARRISON, Colin Fraser
    1 Ladybower Avenue
    Cowlersley
    HD4 5XA Huddersfield
    Director
    1 Ladybower Avenue
    Cowlersley
    HD4 5XA Huddersfield
    United KingdomBritishChief Executive67135490002
    HEBDITCH, Simon Cutcliffe
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    Director
    Victoria House
    10 Brighton Road
    RH1 6QZ Redhill
    Suite 2,
    Surrey
    United KingdomBritishConsultant76044620001
    HUCKETT, Richard
    1 Pipchin Road
    CM1 4XT Chelmsford
    Essex
    Director
    1 Pipchin Road
    CM1 4XT Chelmsford
    Essex
    BritishManager70194590001
    KENYON, Maria Theresa
    The Cottage
    The Stones
    S33 8WX Castleton
    Derbyshire
    Director
    The Cottage
    The Stones
    S33 8WX Castleton
    Derbyshire
    EnglandBritishBusiness Consultant76463210003
    LOVE, Paul James
    C/O Social Firms Scotland
    54 Manor Place
    EH3 7EH Edinburgh
    Director
    C/O Social Firms Scotland
    54 Manor Place
    EH3 7EH Edinburgh
    EnglandBritishManager109501400001

    ¿Tiene SOCIAL FIRMS UK alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 23 ago 2005
    Entregado el 08 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All fixed and floating assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Icof Community Capital Limited
    Transacciones
    • 08 sept 2005Registro de un cargo (410)
    • 04 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0