ASHTENNE CALEDONIA LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ASHTENNE CALEDONIA LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC218018 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Dirección de la sede social | 107 West Regent Street 2nd Floor G2 2BA Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AC&H 125 LIMITED | 11 abr 2001 | 11 abr 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 16 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 30 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 16 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 16 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 9 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 107 West Regent Street 2nd Floor Glasgow G2 2DG Scotland a 107 West Regent Street 2nd Floor Glasgow G2 2BA el 26 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 177 West George Street 5th Floor Glasgow G2 2LB Scotland a 107 West Regent Street 2nd Floor Glasgow G2 2DG el 21 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 ago 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180113 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180118 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180106 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180111 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180117 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180116 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180115 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180114 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180112 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180107 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC2180180105 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 2 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Simon Jeffrey Payne como secretario el 12 may 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga SC2180180147, creada el 08 mar 2024 | 17 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga SC2180180148, creada el 08 mar 2024 | 15 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga SC2180180149, creada el 08 mar 2024 | 14 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga SC2180180150, creada el 08 mar 2024 | 14 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga SC2180180151, creada el 08 mar 2024 | 14 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga SC2180180152, creada el 08 mar 2024 | 14 páginas | MR01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Andrew Richard | Director | West Regent Street 2nd Floor G2 2BA Glasgow 107 Scotland | England | British | 283776100001 | |||||||||
| ROBERTS, Daniel George | Director | West Regent Street 2nd Floor G2 2BA Glasgow 107 Scotland | England | British | 267246940002 | |||||||||
| SPEARING, Glen Stuart | Director | West Regent Street 2nd Floor G2 2BA Glasgow 107 Scotland | Scotland | British | 284967170001 | |||||||||
| STEWART, Graeme Carrigan | Director | West Regent Street 2nd Floor G2 2BA Glasgow 107 Scotland | United Kingdom | British | 304703990001 | |||||||||
| FURMSTON, Teresa | Secretario | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | 210673680001 | |||||||||||
| LANCHESTER, David James | Secretario | 1 Holly Close IG9 6HT Buckhurst Hill Essex | British | 7014460002 | ||||||||||
| LOWES, Richard Phillip | Secretario | 2 Westcott Keep RH6 9US Horley Surrey | British | 5785520001 | ||||||||||
| PAYNE, Simon Jeffrey | Secretario | West George Street 5th Floor G2 2LB Glasgow 177 Scotland | 304168140001 | |||||||||||
| ARCHIBALD CAMPBELL & HARLEY | Secretario designado corporativo | 37 Queen Street EH2 1JX Edinburgh | 900015860001 | |||||||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England |
| 188126550001 | ||||||||||
| LINK COMPANY MATTERS LIMITED | Secretario corporativo | 34 Beckenham Road Beckenham BR3 4TU Kent The Registry England England |
| 102944500002 | ||||||||||
| COLLINS, Peter William | Director | The Oaks 23 Croft Road RG40 3HX Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 26086560001 | |||||||||
| CRIDGE, Philip Mathew | Director | West George Street 5th Floor G2 2LB Glasgow 177 Scotland | United Kingdom | British | 267173330002 | |||||||||
| FOWLER, William | Director designado | 8c Craighill Gardens EH10 5PY Edinburgh | British | 900021870001 | ||||||||||
| GAME, Robert William | Director | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | United Kingdom | English | 139555050001 | |||||||||
| HAVERY, James Mark | Director | Floor Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th England England | England | British | 203008080001 | |||||||||
| HEATHWOOD, Derek Kevin | Director | Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th Floor England England | Scotland | British | 85468580005 | |||||||||
| HEAWOOD, John Anthony Nicholas | Director | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | United Kingdom | British | 133123780001 | |||||||||
| HOWLETT, Benjamin | Director | West George Street 5th Floor G2 2LB Glasgow 177 Scotland | England | British | 266872710001 | |||||||||
| JONES, Morgan Lewis | Director | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | United Kingdom | British | 10146340004 | |||||||||
| JONES, Morgan Lewis | Director | 4 Camden Close BR7 5PH Chislehurst Kent | England | British | 10146340003 | |||||||||
| KEOGH, Mark William | Director | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | England | Irish | 62140690001 | |||||||||
| LINDSAY, Sarah Jane | Director | Pegasus House 37-32 Sackville Street W1S 3DL London First Floor England And Wales United Kingdom | England | British | 274330770001 | |||||||||
| LOWES, Richard Phillip | Director | Floor Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th England England | England | British | 5785520001 | |||||||||
| MCDONALD, Janine Anne | Director | West George Street 5th Floor G2 2LB Glasgow 177 Scotland | England | British | 90973170001 | |||||||||
| MEADE, Karl Robert | Director | Holly Mount Penn Road HP9 2TS Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 118074370001 | |||||||||
| MOORE, Richard | Director | 88 Alzey Gardens AL5 5SZ Harpenden Hertfordshire | British | 73793650001 | ||||||||||
| OVENS, Mark Douglas | Director | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | United Kingdom | British | 56734030003 | |||||||||
| OVENS, Mark Douglas | Director | Birdhurst 37 The Warren SM5 4EQ Carshalton Surrey | United Kingdom | British | 56734030003 | |||||||||
| STEVENS, Michael John | Director | 32 Woodfield Park HP6 5QH Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 60348780002 | |||||||||
| VAGHELA, Vinod Bachulal | Director | 99 Cathles Road Balham SW12 9LF London | England | British | 5689250001 | |||||||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Director | 6th Floor 80 St Vincent Street G2 5UB Glasgow | United Kingdom | British | 7356840002 | |||||||||
| WATSON, Ian Richard | Director | Floor Clarendon House 12 Clifford Street W1S 2LL London 6th England England | England | British | 68256540001 | |||||||||
| WATSON, Ian Richard | Director | Old Dove House Annables Lane AL5 3PR Harpenden Hertfordshire | England | British | 68256540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ASHTENNE CALEDONIA LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 27 feb 2020 | 345 Park Avenue NY 10154 New York C/O Blackstone Group Inc United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ashtenne Industrial (General Partner) Limited | 06 abr 2016 | Copthall Avenue EC2R 7BH London 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0