THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE
Visión general
| Nombre de la empresa | THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | SC222783 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Dirección de la sede social | Blantyre Health Centre Victoria Street G72 0BS Blantyre South Lanarkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE HAVEN CANCER CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE | 03 sept 2001 | 03 sept 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Anthony Anning como director el 09 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Sadiq-Gilmour como director el 11 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Charles Sage como director el 12 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Watson como director el 29 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Watson como secretario el 29 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Geoffrey Charles Sage el 23 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 14 páginas | MA | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Jonathan Mcluskey como director el 05 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 14 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John York como director el 30 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director John Watson el 07 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jan Calder Smith como director el 20 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario John Watson el 12 jul 2021 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Andrew Downie el 19 ene 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWNIE, Andrew | Director | Sydes Brae Blantyre G72 0TL Glasgow 31 Scotland | Scotland | British | 78866700004 | |||||
| DUNN, Rosalie Therese, Dr | Director | 25 Stewarton Drive Cambuslang G72 8DF Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 56842570002 | |||||
| LOUGHLIN, John | Director | Blantyre Health Centre Victoria Street G72 0BS Blantyre South Lanarkshire | Scotland | British | 228491190001 | |||||
| MCLUSKEY, Michael Jonathan | Director | Victoria Street Blantyre G72 0BS Glasgow The Haven, Blantyre Health Centre Scotland | Scotland | British | 295499040001 | |||||
| SADIQ-GILMOUR, Ian | Director | Blantyre Health Centre Victoria Street G72 0BS Blantyre South Lanarkshire | Scotland | British | 340310230001 | |||||
| DOWNIE, Marie Theresa | Secretario | 25 Woodburn Avenue G72 9BA Blantyre South Lanarkshire | British | 77727940001 | ||||||
| MATHIE, Linda Marie | Secretario | 2 Hunthill Lane G72 9RT High Blantyre South Lanarkshire | British | 82563410001 | ||||||
| MCCAFFERTY, Ann | Secretario | 6 Nairn Avenue G72 9NF Blantyre South Lanarkshire | British | 78678690001 | ||||||
| NIMMO, James Craig | Secretario | Kane Place Stonehouse ML9 3NR Larkhall 57 Lanarkshire Scotland | British | 178063770001 | ||||||
| THOMSON, Margaret | Secretario | 46 Rannoch Court High Blantyre G72 0YT South Lanarkshire | British | 96439090001 | ||||||
| WATSON, John | Secretario | Pilgrim Place Guardbridge KY16 0FP St Andrews 2 Fife United Kingdom | 195763390001 | |||||||
| AIRD, John | Director | 67 Station Road G72 9AE Blantyre Lanarkshire | United Kingdom | British | 101960400001 | |||||
| ANNING, John Anthony | Director | Victoria Street G72 0BS Blantyre The Haven Blantyre Health Centre Scotland | Scotland | British | 160593950002 | |||||
| CAMPBELL, John | Director | Cherryhill View ML9 1BD Larkhall 7 South Lanarkshire | United Kingdom | British | 133207450001 | |||||
| CARTY, Robert Michael | Director | 6 Fife Crescent G71 8DG Bothwell Lanarkshire | British | 124870470001 | ||||||
| DODD, Frances | Director | Blaeshill Road Gardenhall G75 8PL East Kilbride 33 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 187769130001 | |||||
| DOWNIE, Marie Theresa | Director | 25 Woodburn Avenue G72 9BA Blantyre South Lanarkshire | British | 77727940001 | ||||||
| FERRIE, Alastair Thomas | Director | 12 Cherrytree Drive G72 7XZ Glasgow South Lanarkshire | British | 79245370001 | ||||||
| FERRIE, Linda | Director | 12 Cherrytree Drive Cambuslang G72 7XZ South Lanarkshire | British | 79405050001 | ||||||
| GORDON, James Stewart Thomas | Director | 4 Silverbirch Gardens Quarter ML3 7YN Hamilton Lanarkshire | Scotland | British | 103583970001 | |||||
| HEANEY, John Clarkson | Director | 1 Fruin Rise ML3 9UY Hamilton South Lanarkshire | British | 78678710001 | ||||||
| LECKENBY, Lesley | Director | 16 Bellflower Grove G74 4TB Glasgow | British | 84569940001 | ||||||
| LEE, William Thomas | Director | 7 Auchincampbell Road ML3 6PE Hamilton Lanarkshire | British | 58322270001 | ||||||
| LENNOX, Ellen Marian | Director | 49 Armour Court G72 9TS High Blantyre | British | 70499840002 | ||||||
| MATHIE, Linda Marie | Director | 2 Hunthill Lane G72 9RT High Blantyre South Lanarkshire | British | 82563410001 | ||||||
| MAY, Brigid Margaret | Director | 9 East Greenlees Drive G72 8TY Glasgow | British | 78678790001 | ||||||
| MCAULEY, Gillian Joan | Director | Main Street Uddingston G71 7LR Glasgow 58a Scotland | Scotland | Uk | 206217230003 | |||||
| MCBETH, Frances | Director | 35 Buchanan Drive Rutherglen G73 3PF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 312750001 | |||||
| MCCAFFERTY, Ann | Director | 6 Nairn Avenue G72 9NF Blantyre South Lanarkshire | British | 78678690001 | ||||||
| NIMMO, James Craig | Director | Kane Place Stonehouse ML9 3NR Larkhall 57 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 1029720002 | |||||
| PINION, Janet Barr | Director | Ness Drive Blantyre G72 9RU Glasgow 36 United Kingdom | United Kingdom | British | 77727930002 | |||||
| PURCELL, Katrina Laidlaw | Director | 2458 Dumbarton Road G14 0PY Glasgow Strathclyde | British | 78678830001 | ||||||
| REIDFORD, Bruce Mills | Director | Calderpark Road Keepers Gate G71 7RG Uddingston 21 Glasgow Scotland | Scotland | British | 67879400003 | |||||
| SAGE, Geoffrey Charles | Director | Westwood Avenue PE15 8AX March 49 England | England | British | 255132950002 | |||||
| SHORTER, Robert William | Director | 8 Ravenswood Road ML10 6JB Strathaven Lanarkshire | Scotland | British | 86137320001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE HAVEN CARING COUNSELLING COMMUNICATION CENTRE?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 03 sept 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0