TIGERMETAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TIGERMETAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC223218 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TIGERMETAL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra TIGERMETAL LIMITED?
Dirección de la sede social | Rowallan Business Park Southcraig Avenue KA3 6BQ Kilmarnock Ayrshire United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIGERMETAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
FOOD PARTNERS HOLDINGS LIMITED | 27 feb 2002 | 27 feb 2002 |
SANDCIRCLE LIMITED | 14 sept 2001 | 14 sept 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TIGERMETAL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 02 oct 2010 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TIGERMETAL LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIGERMETAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Renuncia del auditor | 3 páginas | AUD | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steve Wood como director el 31 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Steve Wood el 01 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Gavin Cox el 01 nov 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher Thomas el 01 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Gavin Cox el 01 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 10 abr 2012
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed food partners holdings LIMITED\certificate issued on 27/04/12 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Kingsley-Bates como director el 28 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Gavin Cox como secretario el 01 oct 2011 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Julian Akhtar Karim Momen como director el 01 oct 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Julian Akhtar Karim Momen como secretario el 01 oct 2011 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Steve Wood como director el 01 sept 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 oct 2010 | 13 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2010 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Gavin Cox el 02 sept 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Gavin Cox como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 03 oct 2009 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Julian Akhtar Karim Momen como secretario | 3 páginas | AP03 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TIGERMETAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX, Gavin | Secretario | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | 165757080001 | |||||||
COX, Gavin Eliot | Director | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | Director | 153840250001 | ||||
THOMAS, Christopher | Director | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63844650001 | ||||
MOMEN, Julian Akhtar Karim | Secretario | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 | British | 150619500001 | ||||||
ROBERTSON, Neil Charles | Secretario | 16 Barmstedt Drive LE15 6RG Oakham Rutland | British | Chartered Accountant | 48323870001 | |||||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
P & W SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Investment House 6 Union Row AB21 7DQ Aberdeen | 900021250001 | |||||||
ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Director | Allee Du Cloitre 7 FOREIGN Brussels 1000 Belgium | British | Director | 71513420001 | |||||
HAZELDEAN, William James | Director | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | Company Director | 83660790002 | ||||
KILSHAW, David Charles | Director | Drumallan 283 North Deeside Road, Cults AB15 9PA Aberdeen | United Kingdom | British | Industrial Manager | 18455470002 | ||||
KINGSLEY-BATES, Paul | Director | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 193929530001 | ||||
LAINE, Jean-Claude | Director | Montan 31450 Montbrun-Les France | French | Fem Partner | 94945290001 | |||||
MCLELLAND, Stewart | Director | 36 East Craigs Rigg EH12 8JA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Director | 157009150001 | ||||
MOMEN, Julian Akhtar Karim | Director | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | England | British | Director | 51784930002 | ||||
POCOCK, Patrick William | Director | The Steadings Woodside Of Cloghill, Kingswells AB15 8SA Aberdeen | British | Company Director | 96978470001 | |||||
ROBERTSON, Neil Charles | Director | 16 Barmstedt Drive LE15 6RG Oakham Rutland | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 48323870001 | ||||
ROBINSON, Stuart John | Director | Westfield House Harburn EH55 8RB West Calder West Lothian | British | Director | 63448390001 | |||||
THORNE, Mike | Director | 40 Lancaster Mews W2 3QF London England | British | Director | 71735980004 | |||||
THUFASON, Henrik | Director | Casa Aslan 29754 Competa (Malaga) Spain | Danish | Banker | 90841950001 | |||||
TRUELOVE, Amelia Anne | Director | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | Director | 37845970003 | |||||
WOOD, Steven John | Director | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | Director | 232132390001 | ||||
WRIGHT, Robin James Morrison | Director | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | Director | 71513490001 | ||||
P & W DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | Investment House 6 Union Row AB21 7DQ Aberdeen | 900021240001 |
¿Tiene TIGERMETAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 21 abr 2008 Entregado el 02 may 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed charges over property, assets and intellectual property including security assignments and floating charge over whole assets of the company - see form 410 for full details. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Floating charge | Creado el 04 abr 2006 Entregado el 21 abr 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Floating charge | Creado el 02 abr 2006 Entregado el 21 abr 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Floating charge | Creado el 31 oct 2001 Entregado el 07 nov 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0