MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED

MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC229058
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED?

    • (7487) /

    ¿Dónde se encuentra MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ANDSTRAT (NO.147) LIMITED12 mar 200212 mar 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    5 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 mar 2011

    Estado de capital el 30 mar 2011

    • Capital: GBP 117,098
    SH01

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Estado de capital el 23 feb 2011

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    2 páginasDS02

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de David Gaffney como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robin Johnson como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Joanne Elizabeth Massey como secretario

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809230001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Secretario
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    BritishDirector78545300002
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Secretario
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    BritishAccountant67033440002
    ANDERSON STRATHERN WS
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    900020500001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretario designado corporativo
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BROWN, Simon Thomas David
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor118942920001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    KERR, John Neilson
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor65694070001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Director
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant94163020001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Director
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritishAccountant78545300002
    O'CALLAGHAN, Sean James
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    Director
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    BritishManaging Director Designate101412420001
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Director
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritishChartered Surveyor142078700006
    SNEDDON, Lisa Marion
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    Director
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    BritishSales Director101413820001

    ¿Tiene MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 14 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Floating charge
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 08 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2009Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Floating charge
    Creado el 05 abr 2004
    Entregado el 16 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 abr 2004Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Standard security
    Creado el 23 abr 2002
    Entregado el 03 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    163-167 ingram street and 92 glassford street, glasgow-GLA115087.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 may 2002Registro de un cargo (410)
    • 03 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 abr 2002
    Entregado el 03 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    159 ingram street and 97-101 hutcheson street, glasgow- GLA143786.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 may 2002Registro de un cargo (410)
    • 03 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 23 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0