CEC RECOVERY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CEC RECOVERY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC230949 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CEC RECOVERY LIMITED?
- Otros transportes terrestres de pasajeros (49390) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra CEC RECOVERY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Waverley Court 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEC RECOVERY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TIE LIMITED | 24 ago 2004 | 24 ago 2004 |
| TRANSPORT INITIATIVES EDINBURGH LIMITED | 30 abr 2002 | 30 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CEC RECOVERY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CEC RECOVERY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEC RECOVERY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2025 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Hugh John Dunn como director el 30 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cessation de Hugh John Dunn en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jun 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Paul Lawrence en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 may 2025 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2024 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Paul Lawrence como director el 08 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2023 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Edinburgh Trams Office 9 Lochside Avenue Edinburgh Midlothian EH12 9DJ Scotland a Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG | 1 páginas | AD02 | ||
Comptes annuels modifiés établis au 31 mar 2017 | 18 páginas | AAMD | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 18 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CEC RECOVERY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWRENCE, Paul | Director | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court 4 | Scotland | British | 289947030001 | |||||
| BAIN, Edward | Secretario | 43 Mellerstain Road KY2 6UB Kirkcaldy Fife | British | 81661530001 | ||||||
| COYLE, Alan | Secretario | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court 4 Scotland | 167776770001 | |||||||
| SMITH, Nicholas Scott | Secretario | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Level 3, Waverley Court Scotland | British | 164232900001 | ||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||
| ANDERSON, David Alexander | Director | Barclay Drive G84 9RB Helensburgh 24 Argyll & Bute United Kingdom | Scotland | British | 60610420002 | |||||
| BROWN, Ewan | Director | Brucenocke 9 Belmont Drive EH12 6JW Edinburgh | United Kingdom | British | 63394750003 | |||||
| BROWN, James | Director | Ashburn Ramoyle FK15 0BD Dunblane Perthshire | Scotland | British | 59929230001 | |||||
| BURNS, Andrew Douglas, Cllr | Director | 32 Cowan Road EH11 1RH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 69062500001 | |||||
| CHILD, Maureen Margaret, Councillor | Director | 8 Lee Crescent EH15 1LW Edinburgh | Scotland | British | 38674860001 | |||||
| COX, Brian John | Director | Kirknewton House Kirknewton NE71 6XF Wooler Northumberland | England | British | 1436830002 | |||||
| COYLE, Alan | Director | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court 4 Scotland | Scotland | British | 178126530001 | |||||
| CUNNINGHAM, William Shearer, Cllr | Director | 14 (2f2) Dalkeith Road EH16 5BP Edinburgh | British | 99204520001 | ||||||
| DUNN, Hugh John | Director | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court 4 Scotland | Scotland | British | 124746760001 | |||||
| EMERY, Victor Reginald | Director | High Street EH1 1YJ Edinburgh City Chambers | United Kingdom | British | 55862430001 | |||||
| GALLAGHER, William Gerard | Director | 21 Glasgow Road KA3 1TJ Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 68934770001 | |||||
| GEMMELL, Gavin John Norman | Director | 14 Midmar Gardens EH10 6DZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 477280001 | |||||
| HENDERSON, Richard Russell, Councillor | Director | 70 Temple Park Crescent EH11 1HY Edinburgh Midlothian | British | 65269700001 | ||||||
| HENDERSON, Richard Russell, Councillor | Director | 70 Temple Park Crescent EH11 1HY Edinburgh Midlothian | British | 65269700001 | ||||||
| HENDERSON, Ricky, Councillor | Director | 11 New Mart Square EH14 1TJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 123281790001 | |||||
| HOGG, Kenneth James | Director | 15/4 East London Street EH7 4BN Edinburgh | British | 118578970001 | ||||||
| JACKSON, Allan George | Director | 6 Bangholm Loan EH5 3AH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 1281700001 | |||||
| JACKSON, Allan George | Director | 6 Bangholm Loan EH5 3AH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 1281700001 | |||||
| JEFFREY, Richard Benjamin | Director | The Paphle Cleish KY13 0LR Perth & Kinross | United Kingdom | British | 67072660007 | |||||
| KELLY, Karen Elizabeth | Director | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 173635660001 | |||||
| KELLY, CPFA, Karen Elizabeth | Director | 65 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Citypoint United Kingdom | United Kingdom | British | 162664430002 | |||||
| MACKAY, David James | Director | 4 East Harbour Road KY11 3EA Charlestown Fife | Scotland | British | 681850002 | |||||
| MACKENZIE, Gordon Ferguson | Director | 53 Kirkhill Road EH16 5DE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 122810520001 | |||||
| PERRY, Ian | Director | Lilyhill Terrace EH8 7DR Edinburgh 49 | Scotland | British | 127893650001 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Director | 21 Lovedale Road EH14 7DW Balerno Glendaruel | United Kingdom | British | 1318380001 | |||||
| SCALES, Neil | Director | 8 Branscombe Drive Lynford Park M33 5JN Sale Cheshire | United Kingdom | British | 96770240001 | |||||
| STRACHAN, Peter | Director | 22 Kingfisher Drive ST18 0FH Colwich Staffordshire | England | British | 118578930001 | |||||
| WHEELER, Austin Philip Michael, Councillor | Director | 47 Clerwood Gardens Corstorphine EH12 8PX Edinburgh Midlothian | British | 109531880001 | ||||||
| WHEELER, Austin Philip Michael, Councillor | Director | 47 Clerwood Gardens Corstorphine EH12 8PX Edinburgh Midlothian | British | 109531880001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CEC RECOVERY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Lawrence | 06 may 2025 | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court 4 | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Hugh John Dunn | 06 abr 2016 | East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court 4 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0