STONEWEG EU LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STONEWEG EU LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC230964 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STONEWEG EU LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra STONEWEG EU LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STONEWEG EU LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CROMWELL EUROPE LIMITED | 24 feb 2017 | 24 feb 2017 |
| VALAD (EUROPE) LIMITED | 09 dic 2013 | 09 dic 2013 |
| VALAD (EUROPE) PLC | 18 feb 2008 | 18 feb 2008 |
| TEESLAND PLC | 30 abr 2002 | 30 abr 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STONEWEG EU LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para STONEWEG EU LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STONEWEG EU LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert James Cotterell como director el 23 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rui Inacio como director el 23 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy William Sewell el 20 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Cromwell Corporate Secretarial Limited el 04 feb 2025 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2025 au 31 dic 2025 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Pertti Mikael Vanhanen como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Cromwell Director Limited el 14 ene 2025 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Modification des détails de Cromwell European Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 ene 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2024 | 25 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed cromwell europe LIMITED\certificate issued on 13/01/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA United Kingdom a 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA el 13 ene 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Yvan Mermod como director el 07 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Rui Inacio como director el 07 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2023 | 25 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 50 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Pertti Mikael Vanhanen el 10 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy William Sewell el 10 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STONEWEG EU LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONEWEG CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Lochrin Square 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh 1 Scotland |
| 133355520013 | ||||||||||
| COTTERELL, Robert James | Director | 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh 1 Lochrin Square Scotland | United Kingdom | British | 172401090002 | |||||||||
| MERMOD, Yvan | Director | c/o Stoneweg Asset Management Sa 1204 Geneva Boulevard Georges-Favon 8 Switzerland | Switzerland | Swiss | 331008160001 | |||||||||
| SEWELL, Timothy William | Director | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | England | British | 154627410017 | |||||||||
| STONEWEG UK DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England |
| 102622300004 | ||||||||||
| BLAIN, Andrew John | Secretario | 60 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | British | 40585290002 | ||||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Secretario | Floor Unit 16, Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st North Yorkshire England | British | 150221860001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Secretario | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Secretario | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Secretario | Stanley Road TW11 8TX Teddington 86 Middlesex | British | 135717740001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Secretario | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | British | 41925000003 | ||||||||||
| BEARMAN, Christian James Alexander | Director | Floor Unit 16, Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 227996930001 | |||||||||
| BLAIN, Andrew John | Director | 60 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | Scotland | British | 40585290002 | |||||||||
| BROWN, Stewart David | Director designado | 6 Moat Place EH14 1NY Edinburgh | British | 900023690001 | ||||||||||
| COTTERELL, Robert James | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 172401090002 | |||||||||
| HENG, Jeffrey | Director | 438 Alexandra Road 119958 \02-00 Alexandra Point Singapore | Singaporean | 100195010001 | ||||||||||
| HURLEY, Peter Edmund | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | Australia | Australian | 121515110004 | |||||||||
| INACIO, Rui | Director | c/o Stoneweg Asset Management Sa 1204 Geneva Boulevard Georges-Favon 8 Switzerland | Switzerland | Portuguese | 330984340001 | |||||||||
| KARIM, Farhad Mawji | Director | Berkeley Square W1J 5AL London 40 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 150892980001 | |||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Director | Floor Unit 16, Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| KIRKBY, David John | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | Australian | 110761830001 | |||||||||
| LEWIS, Evan Richard Charles | Director | The Monks Barn Watton YO25 9AH Driffield East Yorkshire | England | British | 60192560002 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Director | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Director | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Director | Avenue Louise 541 Ascot Apartments Square Du Bois 1050 Ixelles Bruxelles Belgium | British | 109250000006 | ||||||||||
| MCCARTHY, Martyn James | Director | Floor Unit 16, Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | Australian | 126149680033 | |||||||||
| MCLAUGHLIN, Mark Anthony | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | Netherlands | Irish | 233915880001 | |||||||||
| MURRAY, Alan Adams | Director | 3 Otterburn Park EH14 1JX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 559270001 | |||||||||
| MYERS, Anthony Michael | Director | Berkeley Square W1J 5AL London 40 United Kingdom | England | American | 174882970001 | |||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Director | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | England | British | 135717740001 | |||||||||
| OLIVER, Paul Francis | Director | Curlew House 58 Grove Park Gardens Chiswick W4 3RZ London | United Kingdom | British | 14735150002 | |||||||||
| PEGLER, Michael John | Director | Berkeley Square W1J 5AL London 40 United Kingdom | England | British | 113065790004 | |||||||||
| PICKARD, Rodney David | Director | 4 Anson Close Sandridge AL4 9EN St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 34930210001 | |||||||||
| QUEK SWEE HAN, Stanley, Dr | Director | 438 Alexandra Road 119958 \02-00 Alexandra Point Singapore | Singaporean | 100194280001 | ||||||||||
| SEDDON, David Robert Armour | Director | 81 East Sheen Avenue SW14 8AX London | England & Wales | British | 141822480001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STONEWEG EU LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoneweg European Holdings Limited | 06 abr 2016 | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0