HB (CSCT) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HB (CSCT) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC231364 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HB (CSCT) LIMITED?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra HB (CSCT) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Blairton House Old Aberdeen Road Balmedie AB23 8SH Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HB (CSCT) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| REDROW HOMES (CITY SCOTLAND) LIMITED | 05 feb 2003 | 05 feb 2003 |
| PARK LANE CITY LIMITED | 28 jun 2002 | 28 jun 2002 |
| BLP 2002-31 LIMITED | 10 may 2002 | 10 may 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HB (CSCT) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HB (CSCT) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HB (CSCT) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Michael Ian Scott como director el 13 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Ian Scott como director el 21 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Helen Davies como director el 31 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Barratt Corporate Secretarial Services Limited como secretario el 01 ago 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Bethany Ford como secretario el 31 jul 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Timothy Huw Stone como director el 27 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Neil Robinson como director el 27 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Tlt Llp Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE United Kingdom a Blairton House Old Aberdeen Road Balmedie Aberdeen AB23 8SH el 01 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Neil Robinson como director el 31 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Bethany Ford como secretario el 30 nov 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como director el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como secretario el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 1 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE Scotland a C/O Tlt Llp Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE el 24 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Mr K T Meldrum Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG a Cadworks 9th Floor 41 West Campbell Street Glasgow G2 6SE el 24 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 1 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Clive Thomas Parry como director el 22 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Graham Anthony Cope como director el 22 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Helen Davies como director el 22 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HB (CSCT) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRATT CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom |
| 160289260001 | ||||||||||
| STONE, Timothy Huw | Director | St David's Park CH5 3RX Flintshire Redrow House United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 297709310001 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Secretario | Cadworks 9th Floor G2 6SE 41 West Campbell Street C/O Tlt Llp Glasgow United Kingdom | British | 85842880003 | ||||||||||
| FORD, Bethany | Secretario | St. David's Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire Wales | 316534360001 | |||||||||||
| ROBINSON, David Sean | Secretario | 36a Langside Drive Newlands G43 2QQ Glasgow | British | 97946440001 | ||||||||||
| BLP SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005150001 | |||||||||||
| ANDERSON, Anne Janet | Director | 195 The Moorings St Davids Harbour KY11 9GX Dalgetty Bay Fife | British | 89327260002 | ||||||||||
| CAMPBELL-KELLY, David John | Director | Bridgemere Hosue Yew Tree Close LE8 6BU Willoughby Waterleys Leicestershire | England | British | 179235400001 | |||||||||
| CLARKE, Brian John | Director | 53 Dunellan Road Milngavie G62 7RE Glasgow | Scotland | British | 44877770002 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Director | Cadworks 9th Floor G2 6SE 41 West Campbell Street C/O Tlt Llp Glasgow United Kingdom | England | British | 289766770001 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Director | Turnberry House 12 Swallow Drive CW6 0GD Kelsall Cheshire | United Kingdom | British | 85842880003 | |||||||||
| CROMBIE, Colin | Director | 3 Crinan Place KY11 8FR Dunfermline Fife | British | 111176290001 | ||||||||||
| DAVIES, Helen | Director | Old Aberdeen Road Balmedie AB23 8SH Aberdeen Blairton House Scotland | United Kingdom | British | 83638070001 | |||||||||
| HARVEY, Barry Kendrick | Director | Hollybank Pepper Street Appleton Thorn WA4 4SB Warrington Cheshire | England | British | 46807640004 | |||||||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Director | c/o Anderson Fyfe West George Street G2 2HG Glasgow 140 Scotland | Scotland | British | 147233120001 | |||||||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Director | Cupar Road Lundin Links KY8 6DQ Leven The Stables Fife Scotland | Scotland | British | 147233120001 | |||||||||
| MILLAR, Gordon | Director | Rowan Dale Torwood FK5 4SN Larbert Stirlingshire | Uk | British | 44194920001 | |||||||||
| PARRY, Clive Thomas | Director | c/o Mr K T Meldrum 140 West George Street G2 2HG Glasgow Tlt Llp Scotland | United Kingdom | British | 185415520001 | |||||||||
| PATON, Irene | Director | 17 Dunollie Place G69 8LN Gartcosh South Lanarkshire | United Kingdom | British | 118675640001 | |||||||||
| POWELL, Michael Robert | Director | 8 Kentmere Close SK8 4RD Gatley Cheshire | Great Britain | British | 21740050002 | |||||||||
| ROBINSON, David Sean | Director | 36a Langside Drive Newlands G43 2QQ Glasgow | British | 97946440001 | ||||||||||
| ROBINSON, Neil | Director | St. Davids Park Ewloe CH5 3RX Deeside Redrow House Wales | United Kingdom | British | 179914360001 | |||||||||
| SCOTT, Michael Ian | Director | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||||||
| BLP CREATIONS LIMITED | Director designado corporativo | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005130001 | |||||||||||
| BLP FORMATIONS LIMITED | Director designado corporativo | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005140001 | |||||||||||
| REDROW HOMES LIMITED | Director corporativo | St Davids Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire United Kingdom |
| 77242190001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HB (CSCT) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb (Cpts) Limited | 10 mar 2017 | 140 West George Street G2 2HG Glasgow C/O Tlt Solicitors Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0