HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED

HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC231776
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o HBJ GATELEY
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CITRUS HOTELS LIMITED16 jul 200216 jul 2002
    MM&S (2893) LIMITED21 may 200221 may 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga SC2317760010

    4 páginasMR04

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 21 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jun 2016

    Estado de capital el 21 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2016 au 30 sept 2016

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gary Reginald Davis como director el 17 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga SC2317760011

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2317760009

    4 páginasMR04

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 21 may 2015

    16 páginasRP04

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 21 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 may 2015

    Estado de capital el 27 may 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 jun 2015Clarification A second filed AR01 was registered on 10/06/2015.

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    17 páginasAA

    Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga SC2317760010

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga SC2317760009

    5 páginasMR05

    Déclaration annuelle établie au 21 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de as Company Services Limited como secretario el 31 ago 2014

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY Scotland a C/O Hbj Gateley Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH el 12 sept 2014

    1 páginasAD01

    Estado de capital el 29 may 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    ¿Quiénes son los directivos de HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBERTS, Paul
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    United KingdomBritish168184220001
    GANNEY, Ian Keith
    63 The Ridgeway
    EN6 4BD Cuffley
    Hertfordshire
    Secretario
    63 The Ridgeway
    EN6 4BD Cuffley
    Hertfordshire
    British51407520005
    ROBSON, Gail
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Secretario
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    British100895090001
    AS COMPANY SERVICES LIMITED
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Secretario corporativo
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC316974
    119906300001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    SF SECRETARIES LIMITED
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Scotland
    Secretario corporativo
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC128549
    152751560001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Director
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    DAVIS, Gary Reginald
    Curtiss House
    27 Heritage Avenue
    NW9 5WT London
    Flat 66
    England
    Director
    Curtiss House
    27 Heritage Avenue
    NW9 5WT London
    Flat 66
    England
    EnglandBritish167510270002
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish154267590001
    GANNEY, Ian Keith
    63 The Ridgeway
    EN6 4BD Cuffley
    Hertfordshire
    Director
    63 The Ridgeway
    EN6 4BD Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish51407520005
    HARRINGTON, Richard, Lord
    417 Finchley Road
    NW3 6HT London
    Director
    417 Finchley Road
    NW3 6HT London
    EnglandBritish83558560001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Director
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    MCCORKELL, Stephen
    14a Upper Glenburn Road
    Bearsden
    G61 4BW Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    14a Upper Glenburn Road
    Bearsden
    G61 4BW Glasgow
    Lanarkshire
    British95487890003
    NEWALL, Archibald Patrick
    7 Upper Sutherland Crescent
    G84 9PQ Helensburgh
    Director
    7 Upper Sutherland Crescent
    G84 9PQ Helensburgh
    British70430050002
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Director
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Director
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Director
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    ¿Tiene HOTEL DU VIN (GLASGOW) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 10 abr 2014
    Entregado el 17 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    1 and 2 devonshire gardens glasgow GLA82653. 3 devonshire gardens glasgow GLA114600. Ground floor 4 devonshire gardens glasgow GLA93922. First floor 4 devonshire gardens glasgow GLA64124. Second floor 4 devonshire gardens glasgow GLA64966.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 nov 2014Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 30 ago 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 abr 2014
    Entregado el 15 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 22 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 abr 2014
    Entregado el 11 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All intellectual property, all estates or interest in any freehold or leasehold property, all of the chargors rights and interests in any lease document.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 nov 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 22 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 15 abr 2008
    Entregado el 22 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 abr 2008Registro de un cargo (410)
    • 12 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 01 sept 2006
    Entregado el 15 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    4 devonshire gardens, glasgow GLA93922.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 sept 2006Registro de un cargo (410)
    • 14 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 17 jul 2006
    Entregado el 21 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The subjects known as 1 and 2, 3 and 5 devonshire gardens glasgow gla 82653 gla 114600 and gla 64966 and the subjects being the top most or second floor house of the main building at 4 devonshire gardens, glasgow gla 61396 and the subjects being the middle or first floor house of the building known as 4 devonshire gardens, glasgow gla 64124.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jul 2006Registro de un cargo (410)
    • 14 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 13 jul 2006
    Entregado el 21 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jul 2006Registro de un cargo (410)
    • 25 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 30 jul 2002
    Entregado el 09 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1, 2 & 3 devonshire gardens, glasgow-- title numbers GLA114600, GLA111594 & GLA82653.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 ago 2002Registro de un cargo (410)
    • 18 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 30 jul 2002
    Entregado el 09 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    7, 8 & 9 rothesay terrace and back ground at 10 & 11 rothesay terrace, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 ago 2002Registro de un cargo (410)
    • 05 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 25 jul 2002
    Entregado el 31 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 jul 2002Registro de un cargo (410)
    • 22 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 feb 1990
    Adquirido el 26 nov 2004
    Entregado el 30 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due in terms of the sme standard security conditions dated 27 january 2004
    Breve descripción
    The devonshire hotel, glasgow (title number GLA64966).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 nov 2004Registro de una adquisición (416)
    • 18 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0