TOUCH BIONICS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TOUCH BIONICS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC232512 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TOUCH BIONICS LIMITED?
- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32500) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra TOUCH BIONICS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Integration House Alba Business Park EH54 7EG Livingston West Lothian Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TOUCH BIONICS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TOUCH BIONICS PLC | 02 oct 2014 | 02 oct 2014 |
| TOUCH BIONICS LIMITED | 13 jun 2014 | 13 jun 2014 |
| TOUCH EMAS LIMITED | 07 jun 2002 | 07 jun 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TOUCH BIONICS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TOUCH BIONICS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOUCH BIONICS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sveinn Solvason el 11 abr 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tomas Eiriksson como director el 08 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Guðný Arna Sveinsdóttir como director el 08 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Ossur Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 jun 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Ossur Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Comptes modifiés de filiale exemptée d'audit établis au 31 dic 2020 | 29 páginas | AAMD | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 34 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Theodorus Joseph Lambertus Wilhelmus Van Poorten como director el 01 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon Sigurosson como director el 01 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hugh Gill como director el 01 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Tomas Eiriksson como director el 01 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 15 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TOUCH BIONICS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLVASON, Sveinn Logi | Director | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | Iceland | Icelandic | 207109890002 | |||||||||||||
| SVEINSDÓTTIR, Guðný Arna | Director | 109 Reykjavík Akrasel 16 Iceland | Iceland | Icelandic | 334554540001 | |||||||||||||
| KING, Susan | Secretario | 8 Buckstone Row EH10 6TP Edinburgh | British | 82365770001 | ||||||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Secretario | 10a Dick Place EH9 2JL Edinburgh | British | 37456310002 | ||||||||||||||
| MCGREGOR, Jill Amanda | Secretario | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | 191434580001 | |||||||||||||||
| REYNARD, Martin, Dr | Secretario | Station Road EH27 8BJ Kirknewton The Old Schoolhouse West Lothian Uk | British | 131537440001 | ||||||||||||||
| BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 15 Scotland |
| 79799970001 | ||||||||||||||
| BURNESS LLP | Secretario corporativo | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 99448920001 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||||||
| ALLAN, Sandy | Director | c/o Scottish Health Innovations Ltd Vincent Street G2 5SG Glasgow 206 Scotland | United Kingdom | British | 131641960001 | |||||||||||||
| BORTHWICK, George Cooper, Professor | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 9509780001 | |||||||||||||
| BROWN, John, Dr | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 190745120001 | |||||||||||||
| CADENHEAD, Lynne | Director | 49 Castle Gate G71 7HU Bothwell | Scotland | British | 87524030001 | |||||||||||||
| EIRIKSSON, Tomas | Director | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | Iceland | Icelandic | 294989330001 | |||||||||||||
| FORD, Mark William | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Usa | American | 138542690001 | |||||||||||||
| FORD, Mark William | Director | Gordon Road 45335 Jamestown 1800 Greene County Usa | Usa | American | 138542690001 | |||||||||||||
| GILL, Hugh | Director | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 79680760001 | |||||||||||||
| GILL, Hugh | Director | 22 Redhurst Way Gleniffer Gate PA2 8PY Paisley | United Kingdom | British | 79680760001 | |||||||||||||
| GILLIES, Crawford Scott | Director | 12 Heriot Row EH3 6HP Edinburgh Midlothian | British | 42352800002 | ||||||||||||||
| GOW, David James | Director | 33 Fox Spring Rise EH10 6NE Edinburgh Midlothian | British | 75967370001 | ||||||||||||||
| GRANT, John Albert Martin | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | England | British | 55161940001 | |||||||||||||
| GRANT, John Albert Martin | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | England | British | 55161940001 | |||||||||||||
| MACDONALD, Cameron Mackay | Director | 10 Paxton Close MK46 5PR Olney Buckinghamshire | England | British | 56171470001 | |||||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Director | 10a Dick Place EH9 2JL Edinburgh | Scotland | British | 37456310002 | |||||||||||||
| MCBEATH, David George | Director | Carwinshoch Carrick Riggs KA7 4LB Ayr | British | 68030880002 | ||||||||||||||
| MCGILL, Colin Scott | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | United Kingdom | British | 663080001 | |||||||||||||
| MCGREGOR, Jill Amanda | Director | Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston 3 Ashwood Court United Kingdom | United Kingdom | British | 160432920002 | |||||||||||||
| MEAD, Stuart Edgar | Director | 2 Bury Farm Potter Row HP16 9LU Great Missenden Buckinghamshire | England | British | 98961660001 | |||||||||||||
| MISHRA, Gaurav | Director | Whitacres G53 7LJ Glasgow 56 Lanarkshire Uk | Indian | 134290810001 | ||||||||||||||
| NEWMAN, Philip James | Director | 74 Lye Green Road HP5 3NB Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 13755770004 | |||||||||||||
| PASSERO, Thomas | Director | Kelly Road, PO BOX 82 NY 12740 Grahamsville 47 New York United States | Other | 131854840001 | ||||||||||||||
| PATTULLO, Robert Michael | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 54596190001 | |||||||||||||
| REYNARD, Martin, Dr | Director | Station Road EH27 8BJ Kirknewton The Old Schoolhouse West Lothian Uk | United Kingdom | British | 131537440001 | |||||||||||||
| SIGUROSSON, Jon | Director | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | United States | Icelandic | 207109850001 | |||||||||||||
| STEVENS, Ian Herbert | Director | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 148952800001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TOUCH BIONICS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossur Uk Holding Limited | 11 abr 2016 | Hamilton Road SK1 2AE Stockport Unit No. 1 S. Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0