NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED

NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC238098
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    2nd Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NPFI MANAGEMENT LIMITED19 dic 200219 dic 2002
    NPFI ASSET MANAGEMENT LIMITED07 nov 200207 nov 2002
    MM&S (2932) LIMITED14 oct 200214 oct 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 14 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 oct 2015

    Estado de capital el 30 oct 2015

    • Capital: GBP 80.2
    SH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    48 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jonathan Peter Doberman como director el 04 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nestor Augusto Castillo Borrero como director el 04 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Biif Corporate Services Limited el 01 jul 2015

    1 páginasCH02

    Déclaration annuelle établie au 14 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 nov 2014

    Estado de capital el 06 nov 2014

    • Capital: GBP 80.2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mr Nestor Augusto Castillo Borrero como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Forrest como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Michael Forrest el 21 may 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Forrest el 11 nov 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 14 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 oct 2013

    Estado de capital el 28 oct 2013

    • Capital: GBP 80.2
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Forrest el 09 oct 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Forrest el 01 jun 2012

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Infrastructure Managers Ltd 2Nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF* el 27 ago 2013

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    13 páginasAA

    Cambio de datos del director Biif Corporate Services Limited el 04 sept 2012

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del director Biif Corporate Services Limited el 04 sept 2012

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Infrastructure Managers Limited el 26 feb 2013

    2 páginasCH04

    Déclaration annuelle établie au 14 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Biif Corporate Services Limited el 04 sept 2012

    2 páginasCH02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro05372427
    128530180002
    DOBERMAN, Jonathan Peter
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    Director
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish201234400001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Director corporativo
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06793845
    138240210001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secretario corporativo
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secretario corporativo
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    86014010001
    BARKER, Jeremy Robert
    41 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Director
    41 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    British87277640001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Director
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    Director
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish63131640001
    CLARKE, Laurence Seymour
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    EnglandBritish138241960001
    FORREST, Michael
    c/o Infrastructure Managers Limited
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    Director
    c/o Infrastructure Managers Limited
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United KingdomBritish169634490002
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Director
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Director
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    Director
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    United KingdomBritish85320540001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Director
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Director
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    RAY, Alastair Graham
    Flat 120, Globe Wharf
    205, Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    Director
    Flat 120, Globe Wharf
    205, Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    British100818970001
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Director
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Director
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    ¿Tiene NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 28 jul 2011
    Entregado el 16 ago 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 2011Registro de un cargo (MG01s)
    Charge over securities
    Creado el 28 jul 2011
    Entregado el 16 ago 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all of its present and future right title and interest in and to the following assets: all securities and all related rights and all propety and rights.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 2011Registro de un cargo (MG01s)
    Deed of confirmation to charge over shares
    Creado el 19 dic 2007
    Entregado el 28 dic 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The charging company, in security for the payment or discharge of the secured liabilities, charges and agrees to charge by way of a first charge all the shares together with the related rights from time to time accruing to those shares - see form 410 for further details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 dic 2007Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 19 dic 2007
    Entregado el 28 dic 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 dic 2007Registro de un cargo (410)
    Deed of confirmation to charge over shares
    Creado el 09 nov 2007
    Entregado el 22 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First charge over all shares together with related rights.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 22 nov 2007Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 09 nov 2007
    Entregado el 22 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 22 nov 2007Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 21 dic 2006
    Entregado el 04 ene 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ene 2007Registro de un cargo (410)
    Supplemental agreement to charge over shares
    Creado el 21 dic 2006
    Entregado el 29 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First charge over all the shares and related rights accruing to those shares.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2006Registro de un cargo (410)
    Charge over shares
    Creado el 23 dic 2005
    Entregado el 13 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The charging company, in security for the payment or discharge of the secured liabilities, charges and aggrees to charge by way of a first fixed charge all the shares together with the related rights from time to time accruing to those shares.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2006Registro de un cargo (410)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 2005
    Entregado el 07 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 2006Registro de un cargo (410)
    • 04 ene 2007Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 28 nov 2007Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 28 dic 2007Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0