BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED

BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC240318
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Citypoint
    65 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AIRTRICITY WINDFARM DEVELOPMENT (SCOTLAND) LIMITED01 dic 200301 dic 2003
    HMS (447) LIMITED29 nov 200229 nov 2002

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de Inveralmond House 200 Dunkeld Road Perth PH1 3AQ United Kingdom el 16 abr 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Peter Mchale como secretario el 26 mar 2013

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Stephen Bernard Lilley como director el 26 mar 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter James Mchale como director el 26 mar 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Laurence Jon Fumagalli como director el 26 mar 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Lawrence John Vincent Donnelly como secretario el 27 mar 2013

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Peter Symons Donaldson como director el 27 mar 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Caoimhe Mary Giblin como director el 27 mar 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Richard Smith como director el 27 mar 2013

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2012

    Estado de capital el 03 dic 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Patrick Flynn como director el 17 jul 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    17 páginasAA

    Nombramiento de Patrick Flynn como director

    2 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG03s

    Cese del nombramiento de Paul Dowling como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Peter Symons Donaldson el 20 ene 2011

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCHALE, Peter
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    Secretario
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    177047490001
    FUMAGALLI, Laurence Jon
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    Director
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    EnglandBritish161150500001
    LILLEY, Stephen Bernard
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    Director
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    EnglandBritish115160890001
    MCHALE, Peter James
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    Director
    c/o Greencoat Capital Llp
    Francis Street
    SW1P 1DH London
    15
    England
    EnglandIrish65105040005
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House 200
    Perthshire
    Secretario
    Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House 200
    Perthshire
    British129227760001
    HMS SECRETARIES LIMITED
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Secretario designado corporativo
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    900004320001
    BAKER, Alan
    16 Harbourside
    Kip Village
    PA16 0BF Inverkip
    Renfrewshire
    Director
    16 Harbourside
    Kip Village
    PA16 0BF Inverkip
    Renfrewshire
    ScotlandScottish103351610001
    COWIE, Steven Alexander
    42 Divert Road
    PA19 1EE Gourock
    Director
    42 Divert Road
    PA19 1EE Gourock
    ScotlandBritish77680370001
    DONALDSON, Peter Symons
    PH16 5NF Pitlochry
    Clunie Power Station
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    PH16 5NF Pitlochry
    Clunie Power Station
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131456210001
    DOWLING, Paul Cyril
    Weston
    Carrick Brook, Eadestown
    Naas
    County Kildare
    Ireland
    Director
    Weston
    Carrick Brook, Eadestown
    Naas
    County Kildare
    Ireland
    IrelandIrish111811130002
    FLYNN, Donal Francis
    3 Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    IRISH Dublin
    14
    Ireland
    Director
    3 Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    IRISH Dublin
    14
    Ireland
    IrelandIrish126967800001
    FLYNN, Patrick
    Ravenscourt Office Park
    Sandyford
    Dublin 18.
    Airtricity House
    Ireland
    Director
    Ravenscourt Office Park
    Sandyford
    Dublin 18.
    Airtricity House
    Ireland
    IrelandIrish160281760001
    GIBLIN, Caoimhe Mary
    Ravenscourt Office Park
    Sandyford
    Dublin 18
    Airtricity House
    Ireland
    Director
    Ravenscourt Office Park
    Sandyford
    Dublin 18
    Airtricity House
    Ireland
    IrelandIrish153460940001
    MCADAM, Martin
    35 Glen Lawn Drive
    The Park
    IRISH Cabinteely
    Dublin
    Ireland
    Director
    35 Glen Lawn Drive
    The Park
    IRISH Cabinteely
    Dublin
    Ireland
    Irish94415780001
    MCADAM, Martin
    35 Glen Lawn Drive
    The Park
    IRISH Cabinteely
    Dublin
    Ireland
    Director
    35 Glen Lawn Drive
    The Park
    IRISH Cabinteely
    Dublin
    Ireland
    Irish94415780001
    MURPHY, Senan
    2 Cranford
    Terenure Road West
    IRISH Dublin 6w
    Ireland
    Director
    2 Cranford
    Terenure Road West
    IRISH Dublin 6w
    Ireland
    Irish95157200001
    O'BRIEN, Ciaran
    29 Cloister Way
    IRISH Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Director
    29 Cloister Way
    IRISH Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Irish94415390001
    SMITH, Paul Richard
    Grampian House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Director
    Grampian House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    United KingdomBritish62067440001
    HMS DIRECTORS LIMITED
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Director designado corporativo
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    900016860001
    HMS SECRETARIES LIMITED
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Director designado corporativo
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    900004320001

    ¿Tiene BRAES OF DOUNE HOLDING COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Account charge and agreement
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The accounts, the deposit monies and all entitlements to interest and other rights and benefits accuring to or arising in connection with the deposit monies and debt represented thereby.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (410)
    • 12 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Shares pledge
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledgors whole right, title interest and benefit in and to the pledged securities.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (410)
    • 12 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Assignation in security
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 05 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The company's whole right, title, interest and benefit in and to the assigned documents and all rights of the company relative to the assigned documents.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 05 ene 2006Registro de un cargo (410)
    • 12 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Security agreement
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 28 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First fixed charge over all plant and machinery and all book and other debts.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 28 dic 2005Registro de un cargo (410)
    • 12 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 23 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under any finance document
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2005Registro de un cargo (410)
    • 12 may 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0