THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED

THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC243115
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wheatley House
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 oct 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Anthony Allison como secretario el 14 nov 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Kirsten Mary Craig como secretario el 14 nov 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Steven John Henderson como director el 25 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mrs Elizabeth Mary Walford el 02 nov 2016

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Gordon Sloan como director el 07 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 ene 2016, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    14 páginasAA

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Alastair Cox Dempster como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Kirsten Mary Craig como secretario el 26 feb 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mark Gerard Logan como secretario el 26 feb 2015

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 30 ene 2015, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 ene 2014

    17 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    14 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Granite House 177 Trongate Glasgow Lanarkshire G1 5HF* el 09 sept 2013

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALLISON, Anthony
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    C/O Wheatley House 25
    Scotland
    Secretario
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    C/O Wheatley House 25
    Scotland
    219195280001
    BLYTH, William Michael
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Director
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandBritish173115270001
    HENDERSON, Steven John
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Director
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    ScotlandBritish188575210001
    MACNISH, Alastair Jesse Head
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Director
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandBritish99816290001
    WALFORD, Elizabeth Mary
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Director
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    EnglandBritish104107680001
    CRAIG, Kirsten Mary
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Secretario
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    195502180001
    FOSTER, Angiolina
    2 Myrtle Avenue
    G66 4HP Lenzie
    Lanarkshire
    Secretario
    2 Myrtle Avenue
    G66 4HP Lenzie
    Lanarkshire
    British108506180001
    HENDERSON, Julia Anne
    Easterhill Road
    G84 9JE Helensburgh
    1
    Dunbartonshire
    Secretario
    Easterhill Road
    G84 9JE Helensburgh
    1
    Dunbartonshire
    151265410001
    LENNON, Michael Andrew
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    Secretario
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    British94455270001
    LOGAN, Mark Gerard
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Secretario
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    161332380001
    STEVENSON, Donna Lesley
    Craignethan Road
    G46 6SH Glasgow
    38
    Lanarkshire
    Secretario
    Craignethan Road
    G46 6SH Glasgow
    38
    Lanarkshire
    British100054160003
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secretario corporativo
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    BRAAT, Philip
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    United Kingdom
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    United Kingdom
    United KingdomBritish158559490001
    BRADLEY, Jacqueline
    81 Shawbridge Street
    G43 1SB Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    81 Shawbridge Street
    G43 1SB Glasgow
    Lanarkshire
    British104301360001
    DEMPSTER, Alastair Cox
    Dalshian
    8 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Dalshian
    8 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64015620001
    ELLIOT, Neil
    Flat 8, 8 Glen Loy Place
    G53 7HS Glasgow
    Director
    Flat 8, 8 Glen Loy Place
    G53 7HS Glasgow
    British87483330002
    FORSYTHE, Sandra
    139 Mossvale Road
    Flat2/1
    G33 5PT Glasgow
    Strathclyde
    Director
    139 Mossvale Road
    Flat2/1
    G33 5PT Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritish109271310001
    GARNER, Catherine
    2/2 Park Gardens
    G3 7YE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    2/2 Park Gardens
    G3 7YE Glasgow
    Lanarkshire
    British84553260001
    GLASS, Alexander James
    205 Cleeves Road
    Nitshill
    G53 6SN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    205 Cleeves Road
    Nitshill
    G53 6SN Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish106555210001
    HARPER, Sam
    Flat 7/5, Columba House
    323 Blythswood Court, Anderston
    G2 7PD Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Flat 7/5, Columba House
    323 Blythswood Court, Anderston
    G2 7PD Glasgow
    Lanarkshire
    British87546940001
    HAYES, Sarah Elizabeth
    75 Somerset Road
    EN5 1JD New Barnet
    Hertfordshire
    Director
    75 Somerset Road
    EN5 1JD New Barnet
    Hertfordshire
    British74227670001
    HURCOMBE, Ellen
    123 Haywood Street
    G22 6QF Glasgow
    Director
    123 Haywood Street
    G22 6QF Glasgow
    ScotlandBritish38019010001
    LEONARD, Gerald Richard, Bailie
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish66744820001
    MACGREGOR, Alastair
    91 Baronald Drive
    Kelvindale
    G12 0HP Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    91 Baronald Drive
    Kelvindale
    G12 0HP Glasgow
    Lanarkshire
    British87546810001
    MACNISH, Alastair Jesse Head
    Victoria Road
    PA19 1DH Gourock
    23
    Renfrewshire
    Director
    Victoria Road
    PA19 1DH Gourock
    23
    Renfrewshire
    ScotlandBritish99816290001
    MASON, Christopher Michael, Dr.
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish105452470001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910990001
    MCLEAN, Malcolm
    51 Dowanside Road
    G12 9DW Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    51 Dowanside Road
    G12 9DW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish66416950001
    RYAN, George
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    Director
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    UkBritish133071420001
    SHEDDEN, Alfred Charles
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1213170002
    SLOAN, Gordon
    Ruchazie Road
    G32 6PA Glasgow
    211
    United Kingdom
    Director
    Ruchazie Road
    G32 6PA Glasgow
    211
    United Kingdom
    ScotlandBritish140736710001
    SWEETING, Julien
    4 Chesterfield Grove
    SE22 8RW London
    Director
    4 Chesterfield Grove
    SE22 8RW London
    British87115610001
    WARD, Margaret
    64a Dougrie Road
    Castlemilk
    G45 9NN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    64a Dougrie Road
    Castlemilk
    G45 9NN Glasgow
    Lanarkshire
    British109396100001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    06 abr 2016
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCompany Ltd By Guarantee
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc426094
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignation in security
    Creado el 08 mar 2003
    Entregado el 28 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole rights, title, interest and benefit from time to time in and toa) each assigned finance document b) to the extent that any of the assets or rights assigned are held in trust fro gfl, or in relation to which the rights of gfl are as a beneficiary in a trust ) all of gfl's right title and interest in and to the relevant trust assets and as beneficiary of the trust and c) the related rights of gfl in relation to the assets assigned referred to in (a) and (b).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 2003Registro de un cargo (410)
    • 14 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 08 mar 2003
    Entregado el 28 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 2003Registro de un cargo (410)
    • 14 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0