GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED

GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC244049
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    • fabricación de otros productos de carpintería y ebanistería para la construcción (16230) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MK TIMBER SYSTEMS LIMITED04 sept 200804 sept 2008
    EUROPEAN TIMBER SYSTEMS LIMITED04 feb 200404 feb 2004
    TIMBER KIT & TREATMENT WAREHOUSE LIMITED17 feb 200317 feb 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Estado de capital el 22 dic 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 dic 2015

    • Capital: GBP 2,750,001.00
    4 páginasSH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT el 23 oct 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Cancelación total de la carga SC2440490005

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2440490006

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 mar 2015

    Estado de capital el 06 mar 2015

    • Capital: GBP 2,750,000
    SH01

    Registro de la carga SC2440490005, creada el 12 feb 2015

    19 páginasMR01

    Registro de la carga SC2440490006, creada el 12 feb 2015

    16 páginasMR01

    Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secretario
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147808830001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Director
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Director
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    BERRY, Catherine
    2 Avonhead Avenue
    Cumbernauld
    G67 4RB Lanarkshire
    Secretario
    2 Avonhead Avenue
    Cumbernauld
    G67 4RB Lanarkshire
    British66060190004
    BERRY, Catherine
    2 Avonhead Avenue
    Cumbernauld
    G67 4RB Lanarkshire
    Secretario
    2 Avonhead Avenue
    Cumbernauld
    G67 4RB Lanarkshire
    British66060190004
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    ACS SECRETARIES LIMITED
    19 Glasgow Road
    PA1 3QX Paisley
    Renfrewshire
    Secretario designado corporativo
    19 Glasgow Road
    PA1 3QX Paisley
    Renfrewshire
    900019760001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    HECHT, Walter
    Braehead House
    20 Braehead Road, Thorntonhall
    G74 5AQ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Braehead House
    20 Braehead Road, Thorntonhall
    G74 5AQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish94332950001
    HOLMES, David Scott
    Arnotdene Arnothill Lane
    FK1 5SL Falkirk
    Director
    Arnotdene Arnothill Lane
    FK1 5SL Falkirk
    ScotlandBritish102000001
    INGRAM, David Colin
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    Director
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    British109149390001
    KEENAN, Grant Patrick
    36 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    Director
    36 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    ScotlandBritish111271350001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Director
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCKINNON, Craig William
    53 Newtonlea Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QF Glasgow
    Director
    53 Newtonlea Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QF Glasgow
    ScotlandBritish14490650002
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    Director
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    United KingdomBritish207729000002
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Director
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritish78545300002
    RATHBONE, Kevin
    4 St Mungos View
    EH26 8JA Penicuik
    Midlothian
    Director
    4 St Mungos View
    EH26 8JA Penicuik
    Midlothian
    British13920001
    SCOTT, David
    66 Castle Street
    TD11 3BE Duns
    Berwickshire
    Director
    66 Castle Street
    TD11 3BE Duns
    Berwickshire
    British127153850001
    ACS NOMINEES LIMITED
    19 Glasgow Road
    PA1 3QX Paisley
    Renfrewshire
    Director designado corporativo
    19 Glasgow Road
    PA1 3QX Paisley
    Renfrewshire
    900019750001

    ¿Tiene GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 12 feb 2015
    Entregado el 19 feb 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 19 feb 2015Registro de una carga (MR01)
    • 14 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 12 feb 2015
    Entregado el 19 feb 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 19 feb 2015Registro de una carga (MR01)
    • 14 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 14 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 08 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2009Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 22 jul 2005
    Entregado el 30 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 jul 2005Registro de un cargo (410)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 05 jul 2004
    Entregado el 15 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cattles Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 15 jul 2004Registro de un cargo (410)
    • 04 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0