GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC244049 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
- fabricación de otros productos de carpintería y ebanistería para la construcción (16230) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MK TIMBER SYSTEMS LIMITED | 04 sept 2008 | 04 sept 2008 |
| EUROPEAN TIMBER SYSTEMS LIMITED | 04 feb 2004 | 04 feb 2004 |
| TIMBER KIT & TREATMENT WAREHOUSE LIMITED | 17 feb 2003 | 17 feb 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Estado de capital el 22 dic 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 dic 2015
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC2440490005 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC2440490006 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga SC2440490005, creada el 12 feb 2015 | 19 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga SC2440490006, creada el 12 feb 2015 | 16 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | 147808830001 | |||||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| BERRY, Catherine | Secretario | 2 Avonhead Avenue Cumbernauld G67 4RB Lanarkshire | British | 66060190004 | ||||||
| BERRY, Catherine | Secretario | 2 Avonhead Avenue Cumbernauld G67 4RB Lanarkshire | British | 66060190004 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Secretario | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| ACS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 19 Glasgow Road PA1 3QX Paisley Renfrewshire | 900019760001 | |||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| HECHT, Walter | Director | Braehead House 20 Braehead Road, Thorntonhall G74 5AQ Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 94332950001 | |||||
| HOLMES, David Scott | Director | Arnotdene Arnothill Lane FK1 5SL Falkirk | Scotland | British | 102000001 | |||||
| INGRAM, David Colin | Director | Bridleways Woodcote Green Road KT18 7DN Epsom Surrey | British | 109149390001 | ||||||
| KEENAN, Grant Patrick | Director | 36 South Broomage Avenue FK5 3ED Larbert Stirlingshire | Scotland | British | 111271350001 | |||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Director | Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow 35 Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCKINNON, Craig William | Director | 53 Newtonlea Avenue Newton Mearns G77 5QF Glasgow | Scotland | British | 14490650002 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Director | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| MOTION, Michelle Hunter | Director | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British | 78545300002 | |||||
| RATHBONE, Kevin | Director | 4 St Mungos View EH26 8JA Penicuik Midlothian | British | 13920001 | ||||||
| SCOTT, David | Director | 66 Castle Street TD11 3BE Duns Berwickshire | British | 127153850001 | ||||||
| ACS NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 19 Glasgow Road PA1 3QX Paisley Renfrewshire | 900019750001 |
¿Tiene GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 12 feb 2015 Entregado el 19 feb 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 12 feb 2015 Entregado el 19 feb 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 14 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 08 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 22 jul 2005 Entregado el 30 jul 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 05 jul 2004 Entregado el 15 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0