YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaYOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC245072
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wheatley House, 25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GHA (MANAGEMENT) LIMITED05 mar 200305 mar 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2023

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Josephine Armstrong como director el 02 jun 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2023 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Sheila Margaret Gunn como director el 29 sept 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Mary Walford como director el 29 sept 2021

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga SC2450720002

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2450720004

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2450720003

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Steven John Henderson como director el 30 sept 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Elaine Melrose como director el 30 sept 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2020 sin actualizaciones

    2 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael Mccabe como director el 25 sept 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2019 sin actualizaciones

    2 páginasCS01

    Registro de la carga SC2450720002, creada el 30 oct 2018

    21 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALLISON, Anthony
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Scotland
    Secretario
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Scotland
    224595300001
    ARMSTRONG, Josephine
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Director
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish121182240003
    HENDERSON, Steven John
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Director
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish188575210001
    CRAIG, Kirsten Mary
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Scotland
    Secretario
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Scotland
    British188422900001
    HENDERSON, Julia Anne
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Secretario
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    British151777670001
    LENNON, Michael Andrew
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    Secretario
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    British94455270001
    LOGAN, Mark Gerard
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Secretario
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    British160706540001
    MOIR, Gordon Ivor
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Secretario
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    British150776680001
    STEVENSON, Donna Lesley
    142 Hyndland Road
    G12 9PN Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    142 Hyndland Road
    G12 9PN Glasgow
    Lanarkshire
    British100054160002
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secretario corporativo
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    BLYTH, William Michael
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish173115270001
    DEANS, Colin Stirling
    Flat 21 5 Birness Drive
    G43 1TA Glasgow
    Director
    Flat 21 5 Birness Drive
    G43 1TA Glasgow
    ScotlandBritish103983110001
    DILLON, Margaret Jean
    133 Caldarvan Street
    G22 5RG Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    133 Caldarvan Street
    G22 5RG Glasgow
    Lanarkshire
    UkBritish67916130001
    DOUGAN, Elizabeth
    2 Taylor Place
    Townhead
    G4 0PA Glasgow
    Director
    2 Taylor Place
    Townhead
    G4 0PA Glasgow
    Great BritainBritish86590460001
    FURY, John Gerard
    25 Walnut Road
    G22 6EU Glasgow
    Director
    25 Walnut Road
    G22 6EU Glasgow
    British95858230001
    FYFE, Maria
    10 Ascot Avenue
    G12 0AX Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    10 Ascot Avenue
    G12 0AX Glasgow
    Lanarkshire
    British90275680001
    GOLDIE, John
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish80585870001
    GUNN, Sheila Margaret
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Director
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish52725500002
    HASTIE, John
    House 96 40 Dumbreck Court
    G20 9HE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    House 96 40 Dumbreck Court
    G20 9HE Glasgow
    Lanarkshire
    British111668800001
    ISDALE, Graham
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    United KingdomBritish163723820001
    LEONARD, Gerald Richard, Bailie
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish66744820001
    LOGAN, Mark Gerard
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Director
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish47812710004
    LOGAN, Mark Gerard
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish47812710004
    MASON, Christopher Michael, Dr.
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Giffnock
    East Renfrewshire
    Director
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Giffnock
    East Renfrewshire
    United KingdomBritish105452470001
    MASTERTON, Williamina
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish100910850001
    MASTERTON, Williamina
    50 Beil Drive
    Yoker
    G13 4DB Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    50 Beil Drive
    Yoker
    G13 4DB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910850001
    MCCABE, Michael
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish154804360001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910990001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910990001
    MCGUIRE, Alexander Serrels
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Director
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    United KingdomBritish154804060001
    MCKINVEN, John
    598 Boydstone Road
    Carnwadric
    G46 8NF Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    598 Boydstone Road
    Carnwadric
    G46 8NF Glasgow
    Lanarkshire
    British102007460001
    MCVICAR, John
    58 Leighton Street
    High Ruchill
    G20 9HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    58 Leighton Street
    High Ruchill
    G20 9HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Great BritainBritish120516560001
    MELROSE, Elaine
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Director
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish208961820001
    RYAN, George
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    Director
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    UkBritish133071420001
    SHEDDEN, Alfred Charles
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1213170002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    06 abr 2016
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCompany Ltd By Guarantee
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc426094
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 30 oct 2018
    Entregado el 06 nov 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transacciones
    • 06 nov 2018Registro de una carga (MR01)
    • 20 abr 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 oct 2018
    Entregado el 06 nov 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transacciones
    • 06 nov 2018Registro de una carga (MR01)
    • 20 abr 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 oct 2018
    Entregado el 06 nov 2018
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transacciones
    • 06 nov 2018Registro de una carga (MR01)
    • 20 abr 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 22 dic 2003
    Entregado el 08 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due in respect of the gha liabilities and all obligations under any of the relevant documents
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 ene 2004Registro de un cargo (410)
    • 12 oct 2018Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0