RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC245357 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5th Floor 7 Castle Street EH2 3AH Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APPLY ALTRA LIMITED | 17 may 2011 | 17 may 2011 |
| ALTRA ENERGY LIMITED | 10 mar 2003 | 10 mar 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jens Rebsdorf-Gregersen como director el 11 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lars Krogh como director el 11 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL Scotland a 5th Floor 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH el 10 feb 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Cunningham como secretario el 20 jun 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Charles Thorp como secretario el 20 jun 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 158 Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL Scotland a Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL el 21 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Sovereign House Sovereign House 158 West Regent Street 158 West Regent Street, Glasgow G2 4RL Scotland a 158 Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL el 20 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Edward Martin como director el 31 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor, Langstane House 6 Dee Street Aberdeen AB11 6DR Scotland a Sovereign House Sovereign House 158 West Regent Street 158 West Regent Street, Glasgow G2 4RL el 27 ene 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 15 dic 2015
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Andrew Charles Thorp el 22 may 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ a 3rd Floor, Langstane House 6 Dee Street Aberdeen AB11 6DR el 19 may 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Edward Martin como director el 29 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUNNINGHAM, Timothy James | Secretario | Blackfriars Road SE1 8NW London 240 England | 259730570001 | |||||||
| SIMONSEN, Erik | Director | 2300 Copenhagen Hannemanns Alle 53 Denmark | Denmark | Danish | 188669650001 | |||||
| THORP, Andrew Charles | Secretario | Stanton Road SW20 8RW London 45 England | 197236250001 | |||||||
| WATSON, Patricia | Secretario | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | 160216960001 | |||||||
| WATSON, Patricia | Secretario | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | British | 140429740001 | ||||||
| DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED | Secretario corporativo | 12 Hope Street EH2 4DB Edinburgh | 137092310001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Secretario corporativo | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS LLP | Secretario corporativo | 6th Floor 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza | 137701650001 | |||||||
| STRONACHS | Secretario corporativo | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 50482710001 | |||||||
| AANDERUD-LARSEN, Tor | Director | Thorsholmen 16 3209 Sanefjord Norway | Norwegian | 133401890001 | ||||||
| BARRON, Paul John, Mr. | Director | Woodlands, Chaple Brae Pitcaple AB51 5HJ Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 93485570001 | |||||
| BARTHOLOMEW, Iain Douglas, Dr | Director | 7 Woodside Road HP9 1JG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 192817250001 | |||||
| BAYMAN, Mark | Director | Kinmont Pitcaple AB51 5HJ Inverurie Aberdeenshire | British | 93485450001 | ||||||
| BRATTEBO, Stale | Director | 4056 Tananger Nunsteinveien 23b Norway | Norway | Norwegian | 139549590001 | |||||
| CELENTANO, Raffaele | Director | Kinellar AB21 0RY Aberdeen The Coach House | Scotland | Italian | 141021060001 | |||||
| CHADBOURN, Peter | Director | Dunvegan Aquithie Road AB51 5PD Kemnay Aberdeenshire | Scotland | British | 231962320002 | |||||
| CUNNINGHAM, John Birnie | Director | 9 Crombie Circle Peterculter AB14 0XU Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 111799330001 | |||||
| DUVALL, Stephen Warren | Director | Brawliemuir Farm Johnshaven DD10 0HY Montrose Angus | Scotland | British | 1384050002 | |||||
| DYSJALAND, Per Jarle | Director | Paradisveien 86 4012 Stavanger Paradisveien 86 Norway Norway | Norway | Norwegian | 160181090001 | |||||
| GRUDE, Kjell Enok | Director | N-4352 Kleppe Dynjarvegen 10 Norway | Norway | Norwegian | 148830080001 | |||||
| HATLEM, Per | Director | N-4012 Stavanger Stiftelsegaten 4 Norway | Norway | Norwegian | 166863260001 | |||||
| HATLEM, Per | Director | Stiftelsegaten 4 Norway Stiftelsegaten 4 Norway | Norway | Norwegian | 166863260001 | |||||
| HVISTENDAHL, Frederik | Director | Risnesveien 30 N-4056 Tananger Risnesveien 30 Norway Norway | Norway | Norwegian | 160216580001 | |||||
| KONGSHAUG, Agnar | Director | 4068 8040 Stavanger Apply Sorco As Norway Norway | Norway | Norwegian | 166863670001 | |||||
| KROGH, Lars | Director | 6700 Esbjerg Willemoesgade 2 Denmark | Denmark | Danish | 188668570001 | |||||
| MACKENZIE, William Douglas | Director | Braehead Way Bridge Of Don AB22 8SD Aberdeen 122 Aberdeenshire | Scotland | British | 140430090001 | |||||
| MAGNESEN, Erik | Director | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | Norway | Norwegian | 183326760001 | |||||
| MALDE, Ingvar | Director | Robert Scottsgate 6 4021 Stavanger Norway | Norwegian | 133402170001 | ||||||
| MARTIN, Timothy Edward | Director | Sovereign House 158 West Regent Street G2 4RL 158 West Regent Street, Glasgow Sovereign House Scotland | Scotland | British | 79038320004 | |||||
| MCGOWAN, Daniel Joseph | Director | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | United Kingdom | British | 127755370001 | |||||
| NAIK, Hemantkumar Sumanlal | Director | 13 Riverside Blackhall AB31 6PS Banchory Kincardineshire | Great Britain | British | 101421640001 | |||||
| REBSDORF-GREGERSEN, Jens | Director | 6700 Esbjerg Willemoesgade 2 Denmark | Denmark | Danish | 188683970001 | |||||
| REIN, Jens Kristian | Director | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | Norway | Norwegian | 172691030001 | |||||
| RISE, Arne Magnus | Director | 0250 Oslo Oslo Dronning Muds Gt 11 Norway | Norway | Norwegian | 164765360001 | |||||
| RISE, Arne Magnus | Director | 0484 Oslo Lillogt 5q Norway | Norway | Norwegian | 157636560001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 10 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 04 dic 2003 Entregado el 12 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 03 oct 2003 Entregado el 13 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 17 jul 2003 Entregado el 31 jul 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the agreement dated 9 july 2003 | |
Breve descripción Other debts and non-vesting debts. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0