RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED

RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC245357
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5th Floor 7 Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    APPLY ALTRA LIMITED17 may 201117 may 2011
    ALTRA ENERGY LIMITED10 mar 200310 mar 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Jens Rebsdorf-Gregersen como director el 11 feb 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lars Krogh como director el 11 feb 2021

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL Scotland a 5th Floor 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH el 10 feb 2021

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Timothy James Cunningham como secretario el 20 jun 2019

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Andrew Charles Thorp como secretario el 20 jun 2019

    1 páginasTM02

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    17 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 158 Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL Scotland a Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL el 21 jun 2017

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Sovereign House Sovereign House 158 West Regent Street 158 West Regent Street, Glasgow G2 4RL Scotland a 158 Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL el 20 jun 2017

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Timothy Edward Martin como director el 31 ene 2017

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor, Langstane House 6 Dee Street Aberdeen AB11 6DR Scotland a Sovereign House Sovereign House 158 West Regent Street 158 West Regent Street, Glasgow G2 4RL el 27 ene 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 abr 2016

    Estado de capital el 06 abr 2016

    • Capital: GBP 4,320,453
    SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 15 dic 2015

    • Capital: GBP 4,320,453.00
    4 páginasSH01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    17 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mr Andrew Charles Thorp el 22 may 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ a 3rd Floor, Langstane House 6 Dee Street Aberdeen AB11 6DR el 19 may 2015

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Timothy Edward Martin como director el 29 abr 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CUNNINGHAM, Timothy James
    Blackfriars Road
    SE1 8NW London
    240
    England
    Secretario
    Blackfriars Road
    SE1 8NW London
    240
    England
    259730570001
    SIMONSEN, Erik
    2300
    Copenhagen
    Hannemanns Alle 53
    Denmark
    Director
    2300
    Copenhagen
    Hannemanns Alle 53
    Denmark
    DenmarkDanishLegal Director188669650001
    THORP, Andrew Charles
    Stanton Road
    SW20 8RW London
    45
    England
    Secretario
    Stanton Road
    SW20 8RW London
    45
    England
    197236250001
    WATSON, Patricia
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    Secretario
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    160216960001
    WATSON, Patricia
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    Secretario
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    British140429740001
    DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    Secretario corporativo
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    137092310001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secretario corporativo
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    PAULL & WILLIAMSONS LLP
    6th Floor
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza
    Secretario corporativo
    6th Floor
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza
    137701650001
    STRONACHS
    34 Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario corporativo
    34 Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    Aberdeenshire
    50482710001
    AANDERUD-LARSEN, Tor
    Thorsholmen 16
    3209 Sanefjord
    Norway
    Director
    Thorsholmen 16
    3209 Sanefjord
    Norway
    NorwegianSenior Engineer133401890001
    BARRON, Paul John, Mr.
    Woodlands, Chaple Brae
    Pitcaple
    AB51 5HJ Inverurie
    Aberdeenshire
    Director
    Woodlands, Chaple Brae
    Pitcaple
    AB51 5HJ Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishProduction Engineer93485570001
    BARTHOLOMEW, Iain Douglas, Dr
    7 Woodside Road
    HP9 1JG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    7 Woodside Road
    HP9 1JG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGeologist192817250001
    BAYMAN, Mark
    Kinmont
    Pitcaple
    AB51 5HJ Inverurie
    Aberdeenshire
    Director
    Kinmont
    Pitcaple
    AB51 5HJ Inverurie
    Aberdeenshire
    BritishChemical Engineer93485450001
    BRATTEBO, Stale
    4056 Tananger
    Nunsteinveien 23b
    Norway
    Director
    4056 Tananger
    Nunsteinveien 23b
    Norway
    NorwayNorwegianCompany Director139549590001
    CELENTANO, Raffaele
    Kinellar
    AB21 0RY Aberdeen
    The Coach House
    Director
    Kinellar
    AB21 0RY Aberdeen
    The Coach House
    United KingdomItalianDirector141021060001
    CHADBOURN, Peter
    Dunvegan
    Aquithie Road
    AB51 5PD Kemnay
    Aberdeenshire
    Director
    Dunvegan
    Aquithie Road
    AB51 5PD Kemnay
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishEngineer231962320002
    CUNNINGHAM, John Birnie
    9 Crombie Circle
    Peterculter
    AB14 0XU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    9 Crombie Circle
    Peterculter
    AB14 0XU Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishDirector111799330001
    DUVALL, Stephen Warren
    Brawliemuir Farm
    Johnshaven
    DD10 0HY Montrose
    Angus
    Director
    Brawliemuir Farm
    Johnshaven
    DD10 0HY Montrose
    Angus
    ScotlandBritishEngineer1384050002
    DYSJALAND, Per Jarle
    Paradisveien 86
    4012 Stavanger
    Paradisveien 86
    Norway
    Norway
    Director
    Paradisveien 86
    4012 Stavanger
    Paradisveien 86
    Norway
    Norway
    NorwayNorwegianSenior Associate160181090001
    GRUDE, Kjell Enok
    N-4352
    Kleppe
    Dynjarvegen 10
    Norway
    Director
    N-4352
    Kleppe
    Dynjarvegen 10
    Norway
    NorwayNorwegianDirector148830080001
    HATLEM, Per
    N-4012
    Stavanger
    Stiftelsegaten 4
    Norway
    Director
    N-4012
    Stavanger
    Stiftelsegaten 4
    Norway
    NorwayNorwegianPartner166863260001
    HATLEM, Per
    Stiftelsegaten 4
    Norway
    Stiftelsegaten 4
    Norway
    Director
    Stiftelsegaten 4
    Norway
    Stiftelsegaten 4
    Norway
    NorwayNorwegianPartner166863260001
    HVISTENDAHL, Frederik
    Risnesveien 30
    N-4056 Tananger
    Risnesveien 30
    Norway
    Norway
    Director
    Risnesveien 30
    N-4056 Tananger
    Risnesveien 30
    Norway
    Norway
    NorwayNorwegianManaging Director160216580001
    KONGSHAUG, Agnar
    4068
    8040
    Stavanger
    Apply Sorco As
    Norway
    Norway
    Director
    4068
    8040
    Stavanger
    Apply Sorco As
    Norway
    Norway
    NorwayNorwegianDirector166863670001
    KROGH, Lars
    6700
    Esbjerg
    Willemoesgade 2
    Denmark
    Director
    6700
    Esbjerg
    Willemoesgade 2
    Denmark
    DenmarkDanishFinance Director188668570001
    MACKENZIE, William Douglas
    Braehead Way
    Bridge Of Don
    AB22 8SD Aberdeen
    122
    Aberdeenshire
    Director
    Braehead Way
    Bridge Of Don
    AB22 8SD Aberdeen
    122
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishDirector140430090001
    MAGNESEN, Erik
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    Director
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    NorwayNorwegianDirector183326760001
    MALDE, Ingvar
    Robert Scottsgate 6
    4021 Stavanger
    Norway
    Director
    Robert Scottsgate 6
    4021 Stavanger
    Norway
    NorwegianFinanciall Controller133402170001
    MARTIN, Timothy Edward
    Sovereign House
    158 West Regent Street
    G2 4RL 158 West Regent Street, Glasgow
    Sovereign House
    Scotland
    Director
    Sovereign House
    158 West Regent Street
    G2 4RL 158 West Regent Street, Glasgow
    Sovereign House
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director79038320004
    MCGOWAN, Daniel Joseph
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    Director
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    United KingdomBritishManaging Director127755370001
    NAIK, Hemantkumar Sumanlal
    13 Riverside
    Blackhall
    AB31 6PS Banchory
    Kincardineshire
    Director
    13 Riverside
    Blackhall
    AB31 6PS Banchory
    Kincardineshire
    Great BritainBritishEngineer101421640001
    REBSDORF-GREGERSEN, Jens
    6700
    Esbjerg
    Willemoesgade 2
    Denmark
    Director
    6700
    Esbjerg
    Willemoesgade 2
    Denmark
    DenmarkDanishRegional Director (Ramboll Oil & Gas Esbjerg)188683970001
    REIN, Jens Kristian
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    Director
    1 Union Wynd
    AB10 1SL Aberdeen
    Union Plaza (2nd Floor)
    NorwayNorwegianCfo172691030001
    RISE, Arne Magnus
    0250 Oslo
    Oslo
    Dronning Muds Gt 11
    Norway
    Director
    0250 Oslo
    Oslo
    Dronning Muds Gt 11
    Norway
    NorwayNorwegianDirector164765360001
    RISE, Arne Magnus
    0484 Oslo
    Lillogt 5q
    Norway
    Director
    0484 Oslo
    Lillogt 5q
    Norway
    NorwayNorwegianCompany Director157636560001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    10 mar 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 04 dic 2003
    Entregado el 12 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 dic 2003Registro de un cargo (410)
    • 23 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creado el 03 oct 2003
    Entregado el 13 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 oct 2003Registro de un cargo (410)
    • 05 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 17 jul 2003
    Entregado el 31 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the agreement dated 9 july 2003
    Breve descripción
    Other debts and non-vesting debts.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 31 jul 2003Registro de un cargo (410)
    • 13 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0