SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC245928 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOTHIAN FIFTY (978) LIMITED | 18 mar 2003 | 18 mar 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 5 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Joseph Mark Linney el 24 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher James Tanner el 24 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr William Spurr el 19 mar 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Shanks Pfi Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 oct 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Spurr como director el 23 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Alfred Cowan como director el 22 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 mar 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanna Griffiths como director el 29 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alistair Daniel Brookes como director el 27 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Alfred Cowan como director el 28 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Ian Cartwright como director el 25 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam Nathaniel Richford como director el 25 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alistair Daniel Brookes como director el 01 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard | Secretario | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | British | 130189950001 | ||||||
| LINNEY, Joseph Mark | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Foresight Group Llp The Shard London England | Scotland | British | 63161960001 | |||||
| RICHFORD, Adam Nathaniel | Director | c/o Mr Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 126705600001 | |||||
| SPURR, William | Director | c/o Mr Philip Griffin-Smith Renewi Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 126011000001 | |||||
| TANNER, Christopher James | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Foresight Group Llp The Shard London | England | British | 134603140001 | |||||
| GIBSON, Carolyn Ann | Secretario | Polo Barn Nairdwood Lane HP16 0QH Great Missenden Buckinghamshire | British | 119043460001 | ||||||
| KAYE, Paul | Secretario | Old Market Place Market Lane Greet GL54 5BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 3245340002 | ||||||
| BURNESS | Secretario designado corporativo | 242 West George Street G2 4QY Glasgow | 900020360001 | |||||||
| BURNESS LLP | Secretario corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| AITCHISON, Nigel Ian | Director | Willow House 29 High Street Silverstone NN12 8US Towcester Northamptonshire | England | British | 88285320001 | |||||
| AVERILL, Michael Charles Edward | Director | Little Meadow Upton Road Dinton HP17 8UQ Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24913560002 | |||||
| BROOKES, Alistair Daniel | Director | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 196460830001 | |||||
| CARTWRIGHT, Robert Ian | Director | c/o Phil Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 73331440001 | |||||
| CLARKE, Michael James | Director | Derwen House Kibblestone Road ST15 8UJ Stone Staffordshire | England | British | 154591790014 | |||||
| COWAN, Mark Alfred | Director | c/o C/O Mr Philip Griffin-Smith Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | Scotland | British | 211107930001 | |||||
| DOWNES, David John | Director | Holden Brook New Barn Lane RH5 5PF Ockley Surrey | United Kingdom | British | 37289200002 | |||||
| EGLINTON, Peter Damian | Director | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | United Kingdom | British | 137660810001 | |||||
| GOODFELLOW, Ian Frederick | Director | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 28725450004 | |||||
| GRIFFITHS, Joanna | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | United Kingdom | British | 176450190001 | |||||
| HARDY, David Michael | Director | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | England | British | 106339430006 | |||||
| HARMER, Andrew Keith | Director | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 129905330002 | |||||
| MCVICKER, Alan William Fullerton | Director | Ballykeel East Tulchan Steadings PH1 3SG Glenalmond Perthshire | British | 142373580001 | ||||||
| MULLIGAN, David Kevin | Director | c/o Mr Philip Griffin-Smith Shanks Group Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 74215210003 | |||||
| PEARSON, Andrew Stephen | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | United Kingdom | British | 91780000001 | |||||
| RAY, Stephen Leslie | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 169241640001 | |||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 139588670003 | |||||
| SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Director | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162166120001 | |||||
| STOCKLEY, Darren | Director | 52 Paddock Gardens SO41 9ES Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 61712020003 | |||||
| SURCH, Christopher | Director | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138144350001 | |||||
| TRANTER, Julian Ashley | Director | Auckland Park, Mount Farm Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House United Kingdom | United Kingdom | British | 148676690001 | |||||
| WAPLES, Christopher Brian | Director | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 41387640003 | |||||
| WELHAM, Fraser Andrew Norton | Director | Pennard Terry Road HP13 6QJ High Wycombe Buckinghamshire | Uk | British | 105268510002 | |||||
| BURNESS (DIRECTORS) LIMITED | Director designado corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900019120001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Laing Environmental Assets Group (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Renewi Pfi Investments Limited | 06 abr 2016 | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Creado el 25 nov 2004 Entregado el 16 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The right,title and interest in and to the assigned agreements, the security guarantees and all of the proceeds thereof. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 25 nov 2004 Entregado el 09 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0