RUBY DCO SIX LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRUBY DCO SIX LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC247115
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RUBY DCO SIX LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RUBY DCO SIX LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUBY DCO SIX LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CLARK MUNRO LIMITED07 jul 200307 jul 2003
    BLP 2003-29 LIMITED02 abr 200302 abr 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RUBY DCO SIX LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUBY DCO SIX LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01
    XCISFUL7

    Modification des détails de Big Pharma Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2023

    2 páginasPSC05
    XCD39U1N

    Domicilio social registrado cambiado de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland a Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP el 18 sept 2023

    1 páginasAD01
    XCCBQGEA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Nombramiento de Thorsten Sprank como director el 31 ago 2023

    2 páginasAP01
    XCBFMOKY

    Cese del nombramiento de Graham Wiseman como director el 31 ago 2023

    1 páginasTM01
    XCBFMOUO

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed clark munro LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name04 sept 2023

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 ago 2023

    RES15
    XCBCV43E

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    XCAOU2JE

    Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    XCAGS39E

    Estado de capital el 16 ago 2023

    • Capital: GBP 0.01
    5 páginasSH19
    YC9YBIOB

    legacy

    1 páginasSH20
    YC9YBIQB

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    YC9YBIE9

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    3 páginasAA
    SBIT313S

    Cese del nombramiento de Wendy Margaret Hall como director el 09 sept 2022

    1 páginasTM01
    XBC5RDQW

    Cese del nombramiento de Nichola Louise Legg como secretario el 09 sept 2022

    1 páginasTM02
    XBC5QTQ8

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04
    YBC31UIZ

    Memorándum y Estatutos

    33 páginasMA
    YBC31XB5

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Ratification of directors 07/09/2022
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Graham Wiseman como director el 07 sept 2022

    2 páginasAP01
    XBC0GREW

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2022 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    XB7C6MZT

    Cese del nombramiento de Christian Keen como director el 18 may 2022

    1 páginasTM01
    XB4CGSSX

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    3 páginasAA
    SAG841U8

    ¿Quiénes son los directivos de RUBY DCO SIX LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPRANK, Thorsten
    International House, Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5
    United Kingdom
    Director
    International House, Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5
    United Kingdom
    EnglandGermanAccountant203900280002
    BAXTER, Anthony
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    Secretario
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector101256650001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    BritishCompany Secretary118563210001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretario
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    LINTS, Simon Philip
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCorporate Financier56429650002
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Secretario designado corporativo
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005150001
    BAXTER, Anthony
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    Director
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector101256650001
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGermanCfo172030260001
    CLARK, Colin Edward
    Abbeyfield House
    Old Town
    AB55 5DQ Keith
    Banffshire
    Director
    Abbeyfield House
    Old Town
    AB55 5DQ Keith
    Banffshire
    United KingdomBritishCompany Director85269300002
    COCHRANE, John
    23 Maxwell Drive
    G74 4HH East Kilbride
    Lanarkshire
    Director
    23 Maxwell Drive
    G74 4HH East Kilbride
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector153437260001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishSolicitor172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGermanFinance Director238936580003
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Director
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritishChief Finance Officer54544790004
    LINTS, Simon Philip
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCorporate Financier56429650002
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGermanFinance Director220582440001
    MCGROARY, Dianne
    31 Dumgoyne Drive
    Bearsden
    G61 3AW Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    31 Dumgoyne Drive
    Bearsden
    G61 3AW Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector66186900001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritishSolicitor162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishCompany Secretary16898700002
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishDirector120451550002
    WINCHESTER, Randolph Dale
    Ash Cottage
    Banff Road
    AB55 5HA Keith
    Aberdeenshire
    Director
    Ash Cottage
    Banff Road
    AB55 5HA Keith
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishDirector80145840001
    WISEMAN, Graham
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishBusiness Consultant299860960001
    BLP CREATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Director designado corporativo
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005130001
    BLP FORMATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Director designado corporativo
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005140001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RUBY DCO SIX LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06 abr 2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc294226
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene RUBY DCO SIX LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 23 mar 2006
    Entregado el 03 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 03 abr 2006Registro de un cargo (410)
    • 13 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 16 nov 2004
    Entregado el 23 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises, 30 seafield street, cullen BNF2121 & 29 seafield street, cullen BNF2020.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 23 nov 2004Registro de un cargo (410)
    • 02 jun 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 10 nov 2004
    Entregado el 15 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    28-30 seafield street, cullen--title number BNF2121 & 29 seafield street, cullen--title number BNF2020.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 15 nov 2004Registro de un cargo (410)
    • 02 jun 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 12 sept 2003
    Entregado el 17 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    69 high street & 1 chapel road, grantown-on-spey.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 17 sept 2003Registro de un cargo (410)
    • 24 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 02 sept 2003
    Entregado el 16 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 16 sept 2003Registro de un cargo (410)
    • 24 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0