MACDONALD HOTELS LIMITED

MACDONALD HOTELS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMACDONALD HOTELS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC247423
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MACDONALD HOTELS LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra MACDONALD HOTELS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Crutherland House And Spa
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MACDONALD HOTELS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MACDONALD HOTELS PLC10 feb 200410 feb 2004
    SKYE LEISURE VENTURES PLC08 abr 200308 abr 2003

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MACDONALD HOTELS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el24 sept 2025
    Próximas cuentas vencen el24 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta26 sept 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MACDONALD HOTELS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 mar 2026
    Próxima declaración de confirmación vence14 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta31 mar 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MACDONALD HOTELS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 26 sept 2024

    42 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Robert Gordon Fraser el 03 jun 2020

    2 páginasCH01

    Exercice comptable précédent raccourci du 25 sept 2024 au 24 sept 2024

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del director Mr Robert Gordon Fraser el 15 may 2025

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Hugh Gillies el 15 may 2025

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Iain Gillies el 15 may 2025

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Donald John Macdonald el 15 may 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr James Dickie Davidson como director el 14 may 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Marjorie Macdonald como director el 14 may 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Stuart Paul Davies como director el 14 may 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Alteraciones a la garantía flotante SC2474230021

    103 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante SC2474230019

    103 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante SC2474230032

    104 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante SC2474230035

    104 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante SC2474230030

    103 páginas466(Scot)

    Registro de la carga SC2474230034, creada el 21 feb 2025

    55 páginasMR01

    Registro de la carga SC2474230035, creada el 21 feb 2025

    13 páginasMR01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ

    1 páginasAD04

    Comptes consolidés modifiés établis au 28 sept 2023

    41 páginasAAMD

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 28 sept 2023

    42 páginasAA

    Cancelación total de la carga SC2474230018

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cancelación total de la carga SC2474230024

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2474230026

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de MACDONALD HOTELS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MACFARLANE, Stephanie Rose
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Secretario
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    318337980001
    DAVIDSON, James Dickie
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish83786790001
    DAVIES, Stuart Paul
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    WalesBritish189892480002
    FRASER, Robert Gordon
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish289448940001
    GILLIES, Hugh
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    United KingdomBritish301475200001
    GILLIES, Iain
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish436470002
    MACDONALD, Donald John
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish557590001
    MACDONALD, Marjorie
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish186033760001
    SMITH, Gerard Henry
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Director
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    United KingdomBritish169821320001
    FRASER, Robert Gordon
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    218645150001
    FRASER, Robert Gordon
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    191035270001
    FRASER, Robert Gordon
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    150227120001
    FRASER, Robert Gordon
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    Secretario
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    British120322350002
    GILMURRAY, Kieran
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    Secretario
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    199214750002
    HEENEY, Caroline
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    309071060001
    MCCREATH, Matthew Brook
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    British165547750001
    ROSS, Mark
    58 Kettilstoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    West Lothian
    Secretario
    58 Kettilstoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    West Lothian
    British106803450001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    ANDERSON, Bruce Smith
    Level 1 Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Ventures Limited
    Director
    Level 1 Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Ventures Limited
    ScotlandBritish73849040001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    BURNETT, Neil Scott
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    Director
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    British93937250001
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Director
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritish104262520001
    COOK, Robert Barclay
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    Director
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    EnglandBritish172635260001
    CUMMING, Andrew John
    Suffolk Lane
    EC4R 0AX London
    1
    United Kingdom
    Director
    Suffolk Lane
    EC4R 0AX London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Director
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100598030001
    FALLS, Aaron Peter
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Director
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish279163090001
    GATELEY, Donald Kenneth
    Level 1 Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Ventures Limited
    Director
    Level 1 Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Ventures Limited
    United KingdomBritish104442220001
    GRANT, Mary Alexander
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    Director
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    United KingdomBritish69815990010
    GUILE, David Andrew
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Director
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish100133280001
    JACKSON, Simon Richard
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    United KingdomBritish194029260001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Director
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MACDONALD, Ruaridh
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Director
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish138199130001
    MCBURNIE, Jason
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    United KingdomBritish202600000001
    MCGILL, Michael Scott
    5 Lygon Road
    EH16 5QD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    5 Lygon Road
    EH16 5QD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish99070570001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MACDONALD HOTELS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Monument/Macdonald Partnership
    Dykedale
    FK15 0DH Dunblane
    Cardrona
    Scotland
    06 abr 2016
    Dykedale
    FK15 0DH Dunblane
    Cardrona
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCorporate
    Autoridad legalUnited Kingdom - Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Cardrona Charitable Trust
    Dykedale
    FK15 0DH Dunblane
    Cardrona
    Scotland
    06 abr 2016
    Dykedale
    FK15 0DH Dunblane
    Cardrona
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCorporate
    Autoridad legalUnited Kingdom - Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0