CRAWLEY SCHOOLS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CRAWLEY SCHOOLS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC248330 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Dirección de la sede social | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ST. VINCENT STREET (389) LIMITED | 25 abr 2003 | 25 abr 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 13 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Michael John Gillespie como secretario el 19 dic 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Anne-Marie Hallett como secretario el 19 dic 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 21 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Marcelino Hermanus Bernardus Grote Gransey el 24 oct 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Anne-Marie Hallett como secretario el 22 dic 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Michael John Gillespie como secretario el 22 dic 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Kenneth John Simpson como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Mathew Jake Grace como director el 10 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Marcelino Hermanus Bernardus Grote Gransey como director el 10 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 abr 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Ion Bruce Balfour como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 jul 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 21 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 21 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Nicola Covington como director el 19 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLESPIE, Michael John | Secretario | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | 330600010001 | |||||||
COVINGTON, Nicola | Director | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9HH London Aberdeen Asset Management United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 207391580001 | ||||
GRACE, Mathew Jake | Director | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | Netherlands | British | Senior Investment Analyst | 295647450001 | ||||
GROTE GANSEY, Marcelino Hermanus Bernardus | Director | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | Netherlands | Dutch | Investment Director | 295647360002 | ||||
CAMERON, Myra Stevenson | Secretario | 2 Regents Gate Bothwell G71 8QU Glasgow | British | 67742610001 | ||||||
DIPPENAAR, Sarah | Secretario | Buchanan Gate Business Park Stepps G33 6FB Glasgow Kelvin House Scotland | 209597830001 | |||||||
GILLESPIE, Michael John | Secretario | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | 239146850001 | |||||||
GILLESPIE, Michael John | Secretario | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | 198141510001 | |||||||
HALLETT, Anne-Marie | Secretario | Buchanan Gate Business Park Stepps G33 6FB Glasgow Kelvin House Scotland | 303565310001 | |||||||
MCATEER, Sarah | Secretario | 36 Mcgurk Way ML4 3PJ Bellshill Lanarkshire | British | Solicitor | 115049420001 | |||||
MCATEER, Sarah | Secretario | 36 Mcgurk Way ML4 3PJ Bellshill Lanarkshire | British | Solicitor | 115049420001 | |||||
STEWART, Wendy | Secretario | 29 Ardbeg Road Carfin ML1 4FE Motherwell Lanarkshire | British | Accountant | 124218150001 | |||||
LYCIDAS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | 900003290001 | |||||||
BALFOUR, Ion Bruce | Director | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9HH London Aberdeen Asset Management United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 192983050001 | ||||
BLAASSE, Wim | Director | Pallanotlaan 3 1902 Mr Castricum Charlotte Van Netherlands | Netherlands | Dutch | Managing Director | 129774710001 | ||||
BROOKS, Peter Barry | Director | The Willows Guildford Road, Ottershaw KT16 0PB Chertsey Surrey | British | Director | 37415120001 | |||||
CAMERON, Myra Stevenson | Director | 2 Regents Gate Bothwell G71 8QU Glasgow | British | Solicitor | 67742610001 | |||||
COVINGTON, Nicola | Director | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9HH London Aberdeen Asset Management United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 207391580001 | ||||
DUNCAN, Harry | Director | 4 Loyal Gardens Bearsden G61 4SA Glasgow | United Kingdom | British | Accountant | 79252670001 | ||||
FIELDER, Richard John | Director | 107 Dore Road Dore S17 3NF Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Quantity Surveyor | 26589570001 | ||||
FREEMAN, Andrew Derek | Director | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | United Kingdom | British | Accountant | 162758120001 | ||||
GREGORY, Richard Alan | Director | Lower Farm Castle Road, Lavendon MK46 4JG Olney Buckinghamshire | United Kingdom | British | Managing Director | 15469480001 | ||||
JOHNSTONE, Benjamin Maurice Edward | Director | Kelvin House Buchanan Gate Business Park G33 6FB Stepps Glasgow | United Kingdom | British | Manager | 165019630001 | ||||
KOOLHAAS, Engel Johan Roelof | Director | 66 Gildenring 3981 Jg Bunnik The Netherlands | Netherlands | Dutch | Fund Manager | 127104180001 | ||||
KUN-DARBOIS, Fabrice Etienne Marie | Director | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9HH London Aberdeen Asset Management United Kingdom | United Kingdom | French | Senior Analyst - Infrastructure Funds | 192983980001 | ||||
MAY, Brian Ward | Director | Church Garth Topcliffe YO7 3PB Thirsk North Yorkshire | England | British | Chief Executive | 78419090001 | ||||
MEADE, Kieron Gerard | Director | 6 Swift Close CV8 1QT Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 126047000001 | ||||
NASH, Paul William | Director | Hopgarden Lane TN13 1PU Sevenoaks Garden Heights Kent | United Kingdom | British | Fund Manager | 131159260001 | ||||
ROSHIER, Angela Louise | Director | Cornhill EC3V 3ND London 1 England | England | British | Finance Director | 175377480001 | ||||
ROSHIER, Angela Louise | Director | St Mary Axe EC2A 8BF London 30 England | United Kingdom | British | Company Director | 133273160001 | ||||
SIMPSON, Kenneth John | Director | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9HH London Aberdeen Asset Management United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Director | 230466080001 | ||||
WADDINGTON, Adam George | Director | St Mary Axe EC2A 8BF London 30 England | England | British | Company Director | 162470530001 | ||||
WHITE, Barry Edward | Director | 8 The Hawthorns EH31 2DZ Gullane East Lothian | Scotland | British | Managing Director | 127094760001 | ||||
WILLIAMS, Christopher Edward Ingouville | Director | Riccarton Road EH49 6HX Linlithgow 59 West Lothian United Kingdom | Scotland | British | Director | 138047880004 | ||||
LYCIDAS NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | 900003280001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CRAWLEY SCHOOLS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smbc Bank International Plc | 06 abr 2016 | Queen Victoria Street EC4V 4EH London 99 England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Crawley Schools (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Buchanan Gate Business Park Stepps G33 6FB Glasgow Kelvin House Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CRAWLEY SCHOOLS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creado el 16 ene 2004 Entregado el 21 ene 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Bond & floating charge | Creado el 16 ene 2004 Entregado el 21 ene 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0