NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC254641 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
- Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (09100) / Explotación de minas y canteras
¿Dónde se encuentra NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Dominion Building Howe Moss Avenue Kirkhill Industrial Estate, Dyce AB21 0GP Aberdeen |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ARGON (ISOTANK) LIMITED | 22 ago 2003 | 22 ago 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan David Draper como director el 01 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Dominion Technology Gases Investment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 ene 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Notification de Dominion Technology Gases Investment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 ene 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Dominion Technology Gases Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 ene 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2018 au 31 mar 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Russel Timothy Davies como director el 01 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carlos Alberto Heitor De Paiva como director el 29 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Alexander Watt como director el 01 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alan David Draper como director el 11 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Cms Cameron Mckenna Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN Scotland a 15 Atholl Crescent Edinburgh Midlothian EH3 8HA | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de D.W. Company Services Limited como secretario el 14 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Brodies Secretarial Services Limited como secretario el 14 jul 2017 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 25 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 15 Midlothian United Kingdom |
| 79799970001 | ||||||||||
| WATT, David Alexander | Director | Howe Moss Avenue Kirkhill Industrial Estate, Dyce AB21 0GP Aberdeen Dominion Building | United Kingdom | British | 238603420001 | |||||||||
| PARK, Bryan | Secretario | Fountain Drive SM5 4AE Carshalton Beeches 8 Surrey | British | 113694470002 | ||||||||||
| POTTER, Neil Francis | Secretario | Howemoss Avenue Kirkhill Industrial Estate AB21 0GP Dyce Dominion Building Aberdeen | British | 148064490001 | ||||||||||
| WELSH, James John | Secretario | Aspen Way Portlethen AB12 4UL Aberdeen 10 Aberdeenshire | British | 88155680004 | ||||||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh 4th Lothian United Kingdom |
| 613080003 | ||||||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||||||
| DAVIES, Russel Timothy | Director | Howemoss Avenue Kirkhill Industrial Estate AB21 0GP Dyce Dominion Building Aberdeen Scotland | United Kingdom | British | 137343500003 | |||||||||
| DRAPER, Alan David | Director | 9th Floor 28020 Madrid Calle Orense 11 Spain | Spain | American | 237984150001 | |||||||||
| KALTRIDER, Scott Wayne | Director | Old Ridgebury Road 06810 Danbury 39 Connecticut Usa | Usa | American | 178073780001 | |||||||||
| MCBRIDE, Maurice | Director | Howemoss Avenue Kirkhill Industrial Estate AB21 0GP Dyce Dominion Building Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 84209480001 | |||||||||
| MCDONALD, Robert John | Director | Kepplestone Gardens AB15 4DH Aberdeen 19 Aberdeenshire | United Kingdom | British | 91895390004 | |||||||||
| PAIVA, Carlos Alberto Heitor De | Director | Calle Orense 28020 Madrid 11 9o. Floor Spain | Spain | Portuguese | 203292610001 | |||||||||
| PARK, Bryan | Director | Fountain Drive SM5 4AE Carshalton Beeches 8 Surrey | England | British | 113694470002 | |||||||||
| POTTER, Neil Francis | Director | Howemoss Avenue Kirkhill Industrial Estate AB21 0GP Dyce Dominion Building Aberdeen | Scotland | British | 148063980001 | |||||||||
| WALLACE, Anthony James | Director | Howe Moss Avenue Kirkhill Industrial Estate, Dyce AB21 0GP Aberdeen Dominion Building | United States | American | 186520410001 | |||||||||
| WELSH, James John | Director | Lochinch Drive Cove AB12 3RY Aberdeen 14 Scotland | Scotland | British | 88155680006 | |||||||||
| YULE, George Kynoch | Director | Rubislaw Den House 162 Anderson Drive AB15 6FR Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 100652810001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Gases Offshore Investments Limited | 14 ene 2019 | Howe Moss Avenue Kirkhill Industrial Estate, Dyce AB21 0GP Aberdeen Dominion Building United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Dominion Technology Gases Holdings Limited | 06 abr 2016 | Howe Moss Avenue Kirkhill Industrial Estate, Dyce AB21 0GP Aberdeen Dominion Building Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene NIPPON GASES OFFSHORE TANKS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 29 oct 2008 Entregado el 04 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 feb 2008 Entregado el 07 feb 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 19 mar 2004 Entregado el 08 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 17 oct 2003 Entregado el 22 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0