THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC257330 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
- Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p. (42990) / Construcción
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MACROCOM (859) LIMITED | 09 oct 2003 | 09 oct 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 37 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Amey Precision House Mcneil Drive Motherwell ML1 4UR Scotland a 272 Bath Street Glasgow G2 4JR el 10 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher Thomas Solley como director el 31 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Oytun Altasli Widmer como director el 26 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr John Gerard Connelly como director el 26 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Oytun Altasli Widmer como director el 26 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr David Epps como director el 22 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alexandra Jane Hardwicke como director el 22 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Neil Andrew Woodburn como director el 09 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alasdair Campbell como director el 09 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Neeti Mukundrai Anand como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Alexandra Jane Hardwicke como director el 27 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 36 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Neeti Mukundrai Anand como director el 27 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Oytun Altasli Widmer como director el 27 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nadiia Kaznacheieva como director el 06 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Neeti Mukundrai Anand como director el 06 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Paul James Hatcher como secretario el 24 may 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Albany Secretariat Limited como secretario el 24 may 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de Hsdl Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England |
| 303585870001 | ||||||||||
| ALTASLI WIDMER, Oytun | Director | c/o Dif Uk Threadneedle Street EC2R 8HP London 62 England | United Kingdom | British | 311755640001 | |||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Director | c/o Dif Uk Threadneedle Street EC2R 8HP London 62 England | England | British | 323811250001 | |||||||||
| EPPS, David | Director | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | England | British | 329746580001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Director | St Andrew Square EH2 2AH Edinburgh 6 Scotland Scotland | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| PEARMAN, Katherine Anne Louise | Director | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 226963920001 | |||||||||
| POUPARD, Natalia | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | England | British | 254916130001 | |||||||||
| SOLLEY, Christopher Thomas | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 Scotland | United Kingdom | British | 166666620001 | |||||||||
| WOODBURN, Neil Andrew | Director | c/o Albany Spc Services Limited 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England | England | British | 137607780003 | |||||||||
| HATCHER, Paul James | Secretario | 3 - 5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England England | 294214050001 | |||||||||||
| MACROBERTS - (FIRM) | Secretario designado corporativo | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | 900018030001 | |||||||||||
| MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 60 York Street G2 8JX Glasgow Capella Building (Tenth Floor) Scotland |
| 130204580001 | ||||||||||
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| ALTASLI WIDMER, Oytun | Director | 62 Threadneedle Street EC2R 8HP London Dif Uk England | United Kingdom | British | 311755640001 | |||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Director | 62 Threadneedle Street EC2R 8HP London Dif Uk England | England | British | 250186840001 | |||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Director | Level 4 2-4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 250186840001 | |||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Director | Level 4 2-4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 250186840001 | |||||||||
| ANDERSON, Derek Orr | Director | 9 The Spinneys KY11 9SL Dalgety Bay Fife | Scotland | British | 161345590001 | |||||||||
| BRADBURY, Richard George | Director | Beech Cottage Beech Lane WA6 6LP Norley Cheshire | British | 42234330002 | ||||||||||
| BREE, Rhona Macdonald | Director | Flat 3/2 64 Miller Street G1 1DT Glasgow Lanarkshire | British | 99563640001 | ||||||||||
| CAMPBELL, Alasdair | Director | Bartholemew Close EC1A 7HH London 1 England England | Scotland | British | 215915630001 | |||||||||
| CHESTER, Jonathan Roger | Director | 2 Giffard Close ST19 9HD Brewood Stafford | British | 94576750001 | ||||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Director | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | Scotland | British | 152971000001 | |||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Director | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | Scotland | British | 152971000001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Director | c/o C/O Hsbc Specialist Fund Management Limited Canada Square E14 5HQ London 8 | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| COPPIN, Andrew John | Director | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building United Kingdom | United Kingdom | British | 130949770001 | |||||||||
| COTTRELL, Keith | Director | 12 Brightlingsea Place E14 8DB London | British | 88691090001 | ||||||||||
| FALERO, Louis Javier | Director | Level 4 2 - 4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 301858300001 | |||||||||
| FALERO, Louis Javier | Director | c/o C/O Dif Idol Lane EC3R 5DD London 2-4 England | England | British | 301858300001 | |||||||||
| FARLEY, Graham | Director | 9 Manor Close Hinstock TF9 2TZ Market Drayton Salop | United Kingdom | British | 183764380001 | |||||||||
| FORSYTH, Peter, Dr | Director | Long Kensome, South Green Kirtlington OX5 3HJ Oxford Oxfordshire | England | British | 207405700001 | |||||||||
| GHAFOOR, Asif | Director | Floor Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 277343840001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Director | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Director | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Director | St. Mary Axe EC3A 8BF London 30 St Mary Axe England | United Kingdom | British | 206362380001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsdl Nominees Limited | 06 abr 2016 | Trinity Road HX1 2RG Halifax Trinity Road England | Sí | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Rsp (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Precision House Mcneil Drive ML1 4UR Holytown Amey Motherwell Scotland | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | The Mound EH1 1YZ Edinburgh Bank Of Scotland Scotland | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0