TAYDALE (GRANTON) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TAYDALE (GRANTON) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC258109 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MITRESHELF 353 LIMITED | 23 oct 2003 | 23 oct 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 10 | 5 páginas | MR04 | ||||||||||
Estado de capital el 07 jul 2016
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Keith Richard Douglas el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | British | 150144100001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Keith Richard | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 91229410003 | |||||||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||||||
| SHARP, Giles Henry | Director | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | New Bond Street W1S 1SB London 80 United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||||||
| BISHOPS | Secretario designado corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900025710001 | |||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario corporativo | St Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 |
| 119967690001 | ||||||||||
| ANDERSON, Alexander | Director | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||||||
| ARMSTRONG, Karen Jean | Director | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 137938400001 | |||||||||
| BROWN, Simon Christopher | Director | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 113724050001 | |||||||||
| BURNS, William Rae | Director | Barnton Grove Barnton EH4 6EJ Edinburgh 24 | United Kingdom | British | 132773610001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||||||
| COPSTICK, Thomas Crawford | Director | B Glasgow Road Ralston PA1 3JR Paisley 227 Renfrewshire Scotland | British | 129081370001 | ||||||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||||||
| FOWLER, Steven | Director | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 101839920001 | |||||||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | Scotland | British | 84605410002 | |||||||||
| HALDANE, Kenneth Douglas | Director | 64 Victoria Road PA2 9PT Paisley Renfrewshire | United Kingdom | British | 94477860001 | |||||||||
| KENNEDY, David Samuel | Director | 1 Glebe Gardens EH12 7SG Edinburgh | British | 93176930001 | ||||||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Director | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Director | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||||||
| KNIGHT, David Jonathan | Director | 24 Margaret Rose Crescent EH10 7EZ Edinburgh | United Kingdom | British | 190746580001 | |||||||||
| MACLEOD, Angus Iain | Director | St Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | Scotland | British | 57667380001 | |||||||||
| MACLEOD, Joanne May | Director | Silvermills EH3 5BF Edinburgh 23/3 | British | 118869790002 | ||||||||||
| MCGOWAN, Jim | Director | 66 Mulben Crescent G53 7EH Glasgow Lanarkshire | British | 123746950001 | ||||||||||
| MITCHELL, David Murray | Director | 9 Kirklands Drive Newton Mearns G77 5FF Glasgow | British | 91206920001 | ||||||||||
| MORAN, Paul Anthony | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 96935230001 | |||||||||
| MORTIMORE, Jon William | Director | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||||||
| PHILLIPS, Richard James | Director | 5 Brighouse Park Court Cramond EH4 6QF Edinburgh | British | 118057520001 | ||||||||||
| YARDLEY, Norman | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||||||
| MITRESHELF DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900025700001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant Homes Group Limited | 06 abr 2016 | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TAYDALE (GRANTON) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 02 feb 2010 Entregado el 15 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Obligations contained in the missives | |
Breve descripción Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 feb 2010 Entregado el 13 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession to residential security agreement | Creado el 29 ene 2010 Entregado el 05 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción First legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leasehold property owned by it, all plant and machinery etc-see form for further details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 29 ene 2010 Entregado el 05 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 09 feb 2004 Entregado el 19 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Plots 26 & 27 granton harbour, edinburgh MID56170. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 09 feb 2004 Entregado el 19 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Plots 26 & 27 at granton harbour, edinburgh MID56170. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 09 feb 2004 Entregado el 17 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Part of two areas of ground forming plots 26 & 27, granton harbour, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 09 feb 2004 Entregado el 12 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Obligations set out in the missives | |
Breve descripción Plots 26 & 27 granton harbpur, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 23 ene 2004 Entregado el 29 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 23 ene 2004 Entregado el 29 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0