IMPACT FUNDING PARTNERS LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | IMPACT FUNDING PARTNERS LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC261186 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Dirección de la sede social | Robertson House 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| VOLUNTARY ACTION FUND | 22 dic 2003 | 22 dic 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Sara Diegoli como director el 05 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Linda Paterson como director el 07 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Cate Nelson-Shaw como secretario el 28 abr 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 28 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Patricia Macfarlane como secretario el 25 oct 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Dr Sara Diegoli el 22 may 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de James Nicol como director el 22 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Jennifer Linda Paterson como director el 21 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Miss Laura Kathleen Steven como director el 21 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Mrs Patricia Imrie el 02 nov 2023 | 1 páginas | CH03 | ||
Nombramiento de Dr Sara Diegoli como director el 28 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr George Finnie como director el 30 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Gary Meek como director el 30 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr James Nicol el 20 dic 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Alison Clare Gibb en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov 2022 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de James Nicol en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mr Grant Robertson Andrew como director el 23 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Gary Meek como director el 23 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON-SHAW, Cate | Secretario | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | 335195600001 | |||||||
| ANDREW, Grant Robertson | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 97480770001 | |||||
| FINNIE, George | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 240422640001 | |||||
| GIBB, Alison Clare | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 302863550001 | |||||
| HAZELHURST, Keeley Ann | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | United Kingdom | British | 210090220002 | |||||
| KOLLIATSAS, Christos | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | Greek,British | 302865160001 | |||||
| STEVEN, Laura Kathleen | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 205240050001 | |||||
| CARTER, Sandra Margaret | Secretario | Bartholomew House (Flat 3) 12 Duncan Street EH9 1SZ Edinburgh Midlothian | British | 71540270001 | ||||||
| GARDINER, Margaret Mckenzie | Secretario | 29 George Street FK15 9HE Dunblane Perthshire | British | 100356100001 | ||||||
| LOGAN, Eleanor Margaret, Dr | Secretario | 15 Queensferry Road EH4 3HB Edinburgh | British | 110456610003 | ||||||
| MACFARLANE, Patricia | Secretario | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | 274204200002 | |||||||
| WIMBLES, Keith Thomas | Secretario | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | British | 276644360001 | ||||||
| AHMAD, Pervin Akhtar Noor | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 197701250001 | |||||
| ALBA, Carlos Matthew | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 151812010001 | |||||
| ANWAR, Anela | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife | Scotland | British | 121090230001 | |||||
| BEDI, Iqbal Singh | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 219717360001 | |||||
| BIBI, Nasra | Director | Unit 14, Dunfermline Business Centre, Izatt Avenue KY11 3BZ Dunfermline Fife | Scotland | British | 165773820001 | |||||
| BILIOURI-GRANT, Daphne | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 263275220001 | |||||
| BRUCE, Ailsa | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 265262180001 | |||||
| CALLAGHAN, Anne Duffy | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 264169660001 | |||||
| CHAUDHRY, Farkhanada | Director | Unit 14, Dunfermline Business Centre, Izatt Avenue KY11 3BZ Dunfermline Fife | Scotland | British | 91475090001 | |||||
| CORR, Bridgid | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | Welsh | 165703570001 | |||||
| CRICHTON, Andrew George | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 259722630001 | |||||
| CUNNINGHAM, Michael | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | British | 83188690002 | |||||
| DANIEL, Ronald | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | British | 85386400001 | |||||
| DIEGOLI, Sara, Dr | Director | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | United Kingdom | Italian | 314037940002 | |||||
| DOWNIE, Carol | Director | The Lodge 227 Dalry Road EH11 2EQ Edinburgh Midlothian | Scotland | Scottish | 66178000001 | |||||
| EDWARDS, Gail Helen | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | United Kingdom | British | 165749060001 | |||||
| ELSLEY, Susan, Dr | Director | 23 Marlborough Street EH15 2BD Edinburgh Lothian | Scotland | British | 87824760001 | |||||
| FIAMANYA, Eric Mensah | Director | Unit 14, Dunfermline Business Centre, Izatt Avenue KY11 3BZ Dunfermline Fife | Scotland | British | 51341690001 | |||||
| GILES, Nina Mai Fung | Director | 69 Niddrie Marischal Grove Craigmillar EH16 4LD Edinburgh | Scotland | British | 96864390001 | |||||
| GRIEVE, Shirley | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | British | 167279470001 | |||||
| GUEST, Douglas | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 165795430001 | |||||
| HANNAH, Angus John | Director | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife | Scotland | British | 185337650001 | |||||
| HAWTHORN, John Ogilvie | Director | 2 Cedar Walk PA18 6BP Wemyss Bay | British | 94683070001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Ms Alison Clare Gibb | 23 nov 2022 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr James Nicol | 30 jun 2022 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Daphne Grant | 16 feb 2022 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Sí |
Nacionalidad: British,Greek País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Joanna Mclaughlin | 09 nov 2016 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0