SCOTLAND GAS NETWORKS PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | SCOTLAND GAS NETWORKS PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | SC264065 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
- Distribución de combustibles gaseosos por tuberías (35220) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
¿Dónde se encuentra SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Dirección de la sede social | Axis House 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOTLAND GAS NETWORKS LIMITED | 01 jun 2005 | 01 jun 2005 |
| BLACKWATER SC A LIMITED | 26 feb 2004 | 26 feb 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Paul Robert Jeffery como director el 01 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher John Murray como director el 01 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Anne Shand como secretario el 06 nov 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 21 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Anthony John King como director el 11 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon David Kilonback como director el 11 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 110 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Afonso Castello-Branco Gois como director el 16 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mathew David Turnell-Henry como director el 16 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Felipe Ortiz como director el 08 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Demes como director el 30 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Alexander Adam como director el 30 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Fungai Makoni como secretario el 01 abr 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Megan Rose Birtwistle como secretario el 15 ene 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christian Herbert Fingerle como director el 13 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 107 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Thomazi como director el 12 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Antoine Jean René Kerrenneur como director el 15 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Jonathan Gross como director el 04 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Laura Sandys como director el 31 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Megan Rose Birtwistle como secretario el 01 nov 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKONI, Fungai | Secretario | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | 334529540001 | |||||||
| ADAM, James Alexander | Director | 10 Portman Square W1H 6AZ London Ontario Teachers’ Pension Plan (Europe) Limited England | England | British,Canadian | 195244550005 | |||||
| BOTHA, Michael John | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | Canada | Canadian | 294271520001 | |||||
| BRUNNING, Charlotte Louise | Director | Portman Square W1H 6AZ London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 242374880001 | |||||
| CATCHPOLE, Martin Paul | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 285580440001 | |||||
| DEMES, David | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | Slovak | 334083960001 | |||||
| GOIS, Afonso Castello-Branco | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | Portuguese | 335866770001 | |||||
| GROSS, Matthew Jonathan | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United States | American | 318295020001 | |||||
| KILONBACK, Simon David | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 218061760001 | |||||
| KING, Anthony John | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 294251820001 | |||||
| LUMLOCK, Rebecca Elizabeth | Director | One Canada Square, 25th Floor Canary Wharf E14 5AA London Brookfield United Kingdom | United Kingdom | British | 294141090001 | |||||
| MURRAY, Christopher John | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 343967590001 | |||||
| ROSENTHAL, Jeffrey | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | Canada | Canadian | 301023190001 | |||||
| SALMON, Nicholas Robin | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 256613430001 | |||||
| SMART, Michael Oswald | Director | 2 St. James's Market SW1Y 4AH London Stepstone Group England | United Kingdom | British | 296382310001 | |||||
| TRIMMER, Paul John Vincent | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 149695050001 | |||||
| TURNELL-HENRY, Mathew David | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 335866750001 | |||||
| WHITTINGTON, Joanna Sarah | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 280100030001 | |||||
| ADAMS, Jonathan Jeffrey | Secretario | Station Approach RH6 9HJ Horley St. Lawrence House Surrey | British | 150692050001 | ||||||
| BIRTWISTLE, Megan Rose | Secretario | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | 315945960001 | |||||||
| DURRANT, Andrew Peter | Secretario | 25 Grimwade Close Brantham CO11 1QY Manningtree Essex | British | 85381310003 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Secretario | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| GRAY, Ailsa Mary | Secretario | 27 Saint Magdalenes Road PH2 0BT Perth | British | 52995340008 | ||||||
| HARDING, Debbie Mary | Secretario | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House, 200 | British | 136476220001 | ||||||
| SHAND, Nicola Anne | Secretario | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey England | 162700880001 | |||||||
| SYLVESTER, Sharmila Virginia | Secretario | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | 290375520001 | |||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Director | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Director | 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London The Leadenhall Building United Kingdom | United Kingdom | British | 203542960001 | |||||
| BUCK, Colin | Director | 8 Northumberland Road CV32 6HA Leamington Spa Warwickshire | England | British | 73844070001 | |||||
| COVASSIN, Tanya Maria | Director | 31 Anderson Avenue M5P 1H5 Toronto Ontario Canada | Canadian | 103424270002 | ||||||
| DOWD, Stephen Donald | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland Scotland | Ontario, Canada | Canadian | 235050150001 | |||||
| DURRANT, Andrew Peter | Director | 25 Grimwade Close Brantham CO11 1QY Manningtree Essex | British | 85381310003 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Director | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| FAIRBAIRN, Mark Robert | Director | The Old Forge Church Lane Bearley CV37 0SL Stratford Upon Avon | England | British | 187772020001 | |||||
| FINGERLE, Christian Herbert, Dr | Director | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | Germany | German | 193691880001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgn Midco Limited | 05 dic 2017 | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Sgn Pledgeco Limited | 04 dic 2017 | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Scotia Gas Networks Limited | 06 abr 2016 | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0