PROJECT SCOTLAND

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPROJECT SCOTLAND
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC267476
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PROJECT SCOTLAND?

    • Otras actividades de trabajo social sin alojamiento n.c.p. (88990) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra PROJECT SCOTLAND?

    Dirección de la sede social
    5-7 Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PROJECT SCOTLAND?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROJECT SCOTLAND?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Pru Whitwell como director el 31 ago 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Fernando Sanchez Malina como director el 31 ago 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Martin Fleming como director el 31 ago 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Linda Joy Holden como director el 31 ago 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 06 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2021

    36 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Segunda presentación para la terminación de Colin Young como director

    5 páginasRP04TM01

    Cese del nombramiento de Colin Young como director el 28 sept 2020

    1 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    06 ene 2021Second Filing The information on the form TM01 has been replaced by a second filing on 06/01/2021

    Cese del nombramiento de Alan John Masson como director el 03 ago 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Emma Karen Little como director el 01 ago 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2020

    36 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Pru Whitwell como director el 25 nov 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Colin Young como director el 25 nov 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Fernando Sanchez Malina como director el 25 nov 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Jopling como director el 06 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2019

    32 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Jopling como director el 01 sept 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 06 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de PROJECT SCOTLAND?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REDDISH, Paul
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Secretario
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    British184538720001
    JAMIESON, Julie-Anne Mary
    Merchiston Avenue
    EH10 4PH Edinburgh
    33
    City Of Edinburgh
    Scotland
    Director
    Merchiston Avenue
    EH10 4PH Edinburgh
    33
    City Of Edinburgh
    Scotland
    ScotlandBritish80941320002
    O'HARE, Raymond Peter
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandBritish151067740001
    SOUTAR, Rucelle
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Secretario
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    British103574760002
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    30-31 Queen Street
    EH2 1JX Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    30-31 Queen Street
    EH2 1JX Edinburgh
    Midlothian
    900000480001
    ALEXANDER, Graeme Ross
    20/7 Brunswick Street
    EH7 5JD Edinburgh
    Director
    20/7 Brunswick Street
    EH7 5JD Edinburgh
    ScotlandBritish62307000003
    ALEXANDER, Graeme Ross
    17b Fettes Row
    EH3 6RH Edinburgh
    Midlothian
    Director
    17b Fettes Row
    EH3 6RH Edinburgh
    Midlothian
    British62307000002
    ARNOLD, Rachael Olive
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish101752840001
    BENSON, Matthew James
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    Director
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    ScotlandBritish30332650006
    DAVIDSON, Euan Ferguson
    12440 La Salvetat Peyrales
    Le Ponteil
    France
    Director
    12440 La Salvetat Peyrales
    Le Ponteil
    France
    British97516160002
    DOUGLAS HOME, Colette Mary
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    United KingdomBritish97516180001
    DUFF, Fiona Fay Macgregor
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    United KingdomBritish122481620001
    FLEMING, Martin
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandBritish253465690001
    FRASER, James Gow
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish135246930001
    FRY, Dominic Lawrence Charlesworth
    Rockfort
    25 Tannoch Drive
    G62 8AR Milngavie
    Director
    Rockfort
    25 Tannoch Drive
    G62 8AR Milngavie
    ScotlandBritish164700450001
    GLEN, John Ronald Kerr
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    Director
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    ScotlandIrish,British134679420002
    GREATREX, Laura Jayne
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Scotland
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Scotland
    ScotlandBritish167873320001
    HOLDEN, Linda Joy
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandBritish168359360002
    JOHNSTON, Brian
    Capelrig Road
    Patterton
    G77 6NR Glasgow
    Walden House
    United Kingdom
    Director
    Capelrig Road
    Patterton
    G77 6NR Glasgow
    Walden House
    United Kingdom
    United KingdomBritish129966880001
    JOPLING, James
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandBritish262691700001
    LIDDELL, Emma
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish194343390001
    LITTLE, Emma Karen
    Palmerston Place
    EH12 5AL Edinburgh
    22a
    Scotland
    Director
    Palmerston Place
    EH12 5AL Edinburgh
    22a
    Scotland
    ScotlandBritish222336900001
    MASSON, Alan John
    High Road
    Spott
    EH42 1RJ Dunbar
    Forge House
    Scotland
    Director
    High Road
    Spott
    EH42 1RJ Dunbar
    Forge House
    Scotland
    ScotlandBritish246669370001
    MCATEER, Ian Henderson
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish31277320005
    MCTAGGART, Patrick Joseph
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandScottish190933940001
    MULGREW, John Gerald
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish86337390001
    OGILVY, Julia Caroline
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish19413900001
    PARKER, Nicholas Sherren
    The Steading
    Stevenson
    EH41 4PU Haddington
    East Lothian
    Director
    The Steading
    Stevenson
    EH41 4PU Haddington
    East Lothian
    ScotlandBritish12016140001
    SANCHEZ MALINA, Fernando
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandGuatemalan266621260001
    SMITH, Mark Joseph
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    Director
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    EnglandBritish186124240001
    THOMSON, George Cameron
    57 Allanvale Road
    FK9 4PA Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    Director
    57 Allanvale Road
    FK9 4PA Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British97516190001
    WADE, Stephanie Ellouise
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    Director
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Scotland
    United KingdomBritish198173230001
    WHITWELL, Pru
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandBritish266622130001
    YARROW, Norman Murray
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    Director
    Hopetoun Street
    EH7 4GH Edinburgh
    20
    ScotlandBritish41627530002
    YOUNG, Colin
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    Director
    Montgomery Street Lane
    EH7 5JT Edinburgh
    5-7
    Scotland
    ScotlandBritish266621590001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PROJECT SCOTLAND?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 may 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene PROJECT SCOTLAND alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 16 abr 2019
    Entregado el 01 may 2019
    Pendiente
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Postcode Innovation Trust
    Transacciones
    • 01 may 2019Registro de una carga (MR01)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0