CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE
Visión general
| Nombre de la empresa | CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | SC270702 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
- Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
| Dirección de la sede social | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 28 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
| Fecha | Descripci ón | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Calum Stevens como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Gillian Petty como director el 23 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Gordon Paul Leishman como director el 23 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Elaine Peacock como director el 23 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 25 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Nathaniel Adeyemi como director el 29 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Elainne Lea Sibbald como director el 29 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Yvonne Thompson como director el 29 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anne O'neill como director el 29 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Patricia Logan como director el 29 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Lee Macleod como director el 10 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Cristina Ruz como director el 19 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 24 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Gerard Mcgovern como director el 24 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Sharon Margaret Mclellan como director el 27 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Heather Clayton como director el 02 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Jessica Margaret Graham como director el 31 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 26 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Susan Young como director el 25 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Sharon Margaret Mclellan como director el 08 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE, Jennifer Elizabeth | Secretario | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | British | 73954160002 | ||||||
| ADEYEMI, Nathaniel | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Nigerien | 330070990001 | |||||
| CLAYTON, Heather | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 309663980001 | |||||
| DIAMOND, Robert John | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 260579450001 | |||||
| FERGUSON, Shona | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 275159490001 | |||||
| LEISHMAN, Gordon Paul | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 331852210001 | |||||
| MACLEOD, Lee | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 325839770001 | |||||
| MCGOVERN, Gerard | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 316603370001 | |||||
| PEACOCK, Elaine | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 331852160001 | |||||
| PETTY, Gillian | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 331875460001 | |||||
| SIBBALD, Elainne Lea | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 330061420001 | |||||
| THOMPSON, Yvonne | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | British | 330060660001 | |||||
| ATKINSON, Patricia Anne | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 185493080001 | |||||
| BELL, Eileen | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 195370110001 | |||||
| BROADHEAD, John | Director | 12 Valleyfield G66 8NN Milton Of Campsie East Dunbartonshire | Scotland | British | 98944140001 | |||||
| CAMPBELL, David Benbow | Director | Rockbank Milngavie G62 8 Glasgow | British | 406960001 | ||||||
| CAMPBELL, Jane | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 254385050001 | |||||
| CAMPBELL, Julia | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | British | 128109950001 | ||||||
| CATHCART, Elizabeth | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 153071470001 | |||||
| CRAWFORD, Dorothy Catherine | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 98944120001 | |||||
| CRAWFORD, Dorothy Catherine | Director | 99 Clober Road G62 7LS Milngavie East Dunbartonshire | United Kingdom | British | 98944120001 | |||||
| DELANEY, David | Director | 80 Ainslie Road Kildrum Cumbernauld G67 2ED Glasgow | Scotland | British | 50764910001 | |||||
| DUNBAR, Ann Elizabeth | Director | 19 Balmoral Drive G61 1DJ Bearsden East Dunbartonshire | British | 126689520001 | ||||||
| FRASER, Margaret Lorna Campbell | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 195370330001 | |||||
| GRAHAM, Katherine Jessica Margaret | Director | Enterprise Centre Ellangowan Court G62 8PH Milngavie East Dunbartonshire | Scotland | Scottish | 275134310001 | |||||
| GROGAN, Bridget | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 153072550001 | |||||
| HAMILTON, Margaret Barr | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 166706570001 | |||||
| HAMILTON, Pauline | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 257156970001 | |||||
| HENDERSON, Susan | Director | James Boyle Square G66 8JN Milton Of Campsie 24 East Dumbartonshire | British | 82989460002 | ||||||
| KAY, Robert Malcolm | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 122904180001 | |||||
| KUJAWA, Simon Peter | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 101106590001 | |||||
| LEE, Douglas George | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 234032330001 | |||||
| LOGAN, Jane Patricia | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 224062280001 | |||||
| MACDONALD, Catherine | Director | St Winnins 16 Ledcameroch Road, Bearsden G61 4AB Glasgow | British | 73555060001 | ||||||
| MACKIE, Ian William | Director | Ellangowan Road Milngavie G62 8PH Glasgow Enterprise Centre United Kingdom | Scotland | British | 158053420001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CARERS LINK, EAST DUNBARTONSHIRE?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 14 jul 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0