QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC273554 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 8 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ Scotland a C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD el 24 feb 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Scott Richard Mccabe como director el 15 ene 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Charles Mccabe como director el 15 ene 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL Scotland a C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ el 01 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy John Tutton como director el 21 ago 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Esplanade Director Limited como director el 21 ago 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Charles Mccabe como director el 21 ago 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Charles Mccabe el 26 nov 2019 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2019 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU a C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL el 04 jul 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 sept 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2018 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2017 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevin Charles Mccabe como director el 30 jul 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AC93 | ||||||||||
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria | 7 páginas | 4.26(Scot) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430250001 | ||||||||||
| MCCABE, Scott Richard | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | England | British | 151895310001 | |||||||||
| TUTTON, Jeremy John | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | United Kingdom | British | 113787520002 | |||||||||
| CAPPER, Simon | Secretario | 3 The Gowans Sutton On The Forest YO61 1DL York North Yorkshire | British | 118147580001 | ||||||||||
| MCCABE, Jo Anne | Secretario | The Lodge 1 Green Lane Lebberston YO11 3PF Scarborough North Yorkshire | British | 66513250002 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Secretario | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Director | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | England | British | 109250000012 | |||||||||
| MCCABE, Scott Richard | Director | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 67294400005 | ||||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Director | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 154915110001 | |||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Director | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 103888320002 | |||||||||
| STACEY, John Marcus William | Director | 245 Windsor Road Carlton In Lindrick S81 9DH Worksop Nottinghamshire | England | British | 112379430001 | |||||||||
| ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430390001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarborough Property Developments Limited | 06 abr 2016 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 01 ago 2014 Entregado el 09 ago 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción 39 mark road, hemel hempstead, HD252081. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 30 jul 2014 Entregado el 14 ago 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 23 ene 2014 Entregado el 03 feb 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Innovation house, 39 mark road, maylands avenue hemel hempstead HD252081. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 may 2011 Entregado el 03 jun 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Debenture | Creado el 20 may 2011 Entregado el 03 jun 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 20 may 2011 Entregado el 03 jun 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 20 may 2011 Entregado el 03 jun 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 mar 2009 Entregado el 03 abr 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Legal mortgage over freehold property known as 39 mark road, hemel hempstead HD252081 and a floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 22 may 2006 Entregado el 03 jun 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción By way of legal mortgage the freehold property known as innovation house, 39 mark street, hemel hempstead, hertfordshire hd 252081. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 10 may 2006 Entregado el 12 may 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects at whitemyres avenue, aberdeen abn 80786. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rental assignation | Creado el 02 may 2006 Entregado el 12 may 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The rent payable under the leases of the property at whitemyres avenue, aberdeen abn 80786. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 30 dic 2005 Entregado el 06 ene 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The lombard centre, kirkhill industrial estate, aberdeen ABN2186. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rental assigantion | Creado el 21 dic 2005 Entregado el 06 ene 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Rents due under the leases of the lombard centre, kirkhill industrial estate, aberdeen ABN2186. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 dic 2005 Entregado el 20 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Ground floor shop premises, 11 high street, penicuik. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rental assignation | Creado el 14 dic 2005 Entregado el 20 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The rent and other sums payable by the tenants under their lease of the ground floor premises 11 high street, penicuik. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 22 nov 2005 Entregado el 28 nov 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 7 melville terrace, stirling STG316. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rental assignation | Creado el 18 nov 2005 Entregado el 28 nov 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Rents payable under leases of 7 melville terrace, stirling STG316. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 may 2005 Entregado el 10 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The ground floor and basement shop premises known as 17 church hill place, edinburgh, in the county of midlothian which subjects form part of the subjects known as 13, 15 and 17 church hill place, edinburgh mid 30547. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 feb 2005 Entregado el 11 feb 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 3-19 whistleberry industrial estate, hamilton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 26 ene 2005 Entregado el 09 feb 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
| |||||||||||||
| 2 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0