REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND

REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREFUGEE SANCTUARY SCOTLAND
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC274440
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    Dirección de la sede social
    Floor 3, Robertson House
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REFUGEE SURVIVAL TRUST09 oct 200409 oct 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta10 nov 2025
    Próxima declaración de confirmación vence24 nov 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta10 nov 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Amy Westendarp como director el 15 ene 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    27 páginasAA

    Nombramiento de Mr Derek George May como director el 07 feb 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ajmal Yamin como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    34 páginasAA

    Nombramiento de Mr Milan Copic como director el 10 oct 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Elizabeth-Mya Chemonges-Murzynowska como director el 09 oct 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mary Agatha Kai-Kai como director el 04 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Monojit Chatterji como director el 04 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Ms Amy Westendarp el 30 may 2023

    2 páginasCH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed refugee survival trust\certificate issued on 05/07/23
    4 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name05 jul 2023

    Aviso de cambio de nombre

    CONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 22 jun 2023

    RES15

    Memorándum y Estatutos

    17 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Katrina Jane Wilson como director el 13 jun 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Ashley Fleming como director el 15 sept 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mahindhan Nadanasabapathy como director el 03 feb 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mahindhan Nadanasabapathy como director el 01 ene 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    36 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Murray como director el 30 jun 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mahindhan Nadanasabapathy como director el 19 dic 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Eva Zuckschwerdt como director el 14 dic 2021

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHEMONGES-MURZYNOWSKA, Elizabeth-Mya
    Station Drive
    Ardersier
    IV2 7RD Inverness
    7
    Scotland
    Director
    Station Drive
    Ardersier
    IV2 7RD Inverness
    7
    Scotland
    ScotlandKenyanEarly Years Practitioner314513690001
    COPIC, Milan
    Park Road
    AB24 5RZ Aberdeen
    130 Oceon Apartments, 52-54
    Scotland
    Director
    Park Road
    AB24 5RZ Aberdeen
    130 Oceon Apartments, 52-54
    Scotland
    ScotlandBritishProduction Director314514110001
    FINER, Emily, Dr
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishSenior Lecturer287984200001
    FLEMING, Ashley
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    United KingdomBritishSenior Associate309578310001
    MAY, Derek George
    Manse Road
    ML1 2PY Motherwell
    142
    United Kingdom
    Director
    Manse Road
    ML1 2PY Motherwell
    142
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinance Director149925790001
    NADANASABAPATHY, Mahindhan
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector227096970001
    TAGWIREYI, Ronald Tapiwa Hlabanai
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandZimbabweanCustomer Services288979240001
    BROOKS, Kerrie
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Secretario
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    179212800001
    MCILWHAN, Rosemarie
    5 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    Secretario
    5 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    British168328830001
    PRICE, Janet Elisabeth
    26/2 Murrayfield Drive
    EH12 6EB Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    26/2 Murrayfield Drive
    EH12 6EB Edinburgh
    Midlothian
    BritishRetired100652790001
    ROSS, Duncan Fraser
    132 Craiglea Drive
    EH10 5PR Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    132 Craiglea Drive
    EH10 5PR Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor108237430001
    ALEXANDER, Catherine
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritishVolunteer189203520001
    ALSABAN, Abdulbaset Abdulwasea Ali
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandYemeniBanks Senior Auditor258236130001
    BAVENDALE, Eileen Janet Gladys
    Larchfield Drive
    Rutherglen
    G73 4HA Glasgow
    1
    South Lanarkshire
    Director
    Larchfield Drive
    Rutherglen
    G73 4HA Glasgow
    1
    South Lanarkshire
    ScotandBritishElected Member South Lanarkshire Council137652350001
    BEALE, Anna
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor179212860001
    BECK, James
    Robertson House
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Refugee Survival Trust
    Scotland
    Director
    Robertson House
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Refugee Survival Trust
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor251795270001
    BOLES, Christopher, Rev
    28 Lauriston Street
    EH3 9DJ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    28 Lauriston Street
    EH3 9DJ Edinburgh
    Midlothian
    BritishJesuit Priest100652780001
    BONELLA, Philippa Mary
    Glengyle Terrace
    EH3 9LL Edinburgh
    8a
    Midlothian
    Director
    Glengyle Terrace
    EH3 9LL Edinburgh
    8a
    Midlothian
    United KingdomBritishSenior Manager, Health Charity153891340001
    BROCK, Jacqueline Elisabeth
    38 Marlborough Street
    EH15 2BG Edinburgh
    Director
    38 Marlborough Street
    EH15 2BG Edinburgh
    ScotlandBritishCivil Servant281233310001
    BROOKS, Kerrie Rebecca Taylor
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritishProject Manager168221020002
    BUJANDA-VALIENTE, Vladimir
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor179212870001
    CHATTERJI, Monojit
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishProfessor258431010001
    CONBOY, Barbara Beryl
    71 Charterhall Grove
    EH9 3HT Edinburgh
    Director
    71 Charterhall Grove
    EH9 3HT Edinburgh
    ScotlandBritishRetired43572590001
    CRICHTON, Judith Anne
    15 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    Director
    15 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant112791730001
    FARMER, Jacqueline Clare Margaret
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritishTrainee Auditor203163750001
    FARRIER, David Christopher, Dr
    Orchard Brae Gardens
    EH4 2HH Edinburgh
    62
    U.K.
    Director
    Orchard Brae Gardens
    EH4 2HH Edinburgh
    62
    U.K.
    U.K.BritishLecturer168220900001
    GARDINER, Angela
    13 Parkgrove Terrace
    G3 7SD Glasgow
    2/2
    Uk
    Director
    13 Parkgrove Terrace
    G3 7SD Glasgow
    2/2
    Uk
    UkBritishProject Coordinator108117570001
    GILLESPIE, Morag Helen
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritishRetired202253820001
    GOLDSMITH, Marion Hilda
    82 Woodfield Park
    EH13 0RB Edinburgh
    Director
    82 Woodfield Park
    EH13 0RB Edinburgh
    BritishCivil Servant100652760002
    GOODWIN, Karin
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritishJournalist202323080001
    GREEN, Mhoraig
    12 Grantley Gardens
    G41 3QA Glasgow
    1/2
    Scotland
    Director
    12 Grantley Gardens
    G41 3QA Glasgow
    1/2
    Scotland
    ScotlandBritishPolicy Officer137652110002
    IBRAHIM, Adnan
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Director
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandIraqiAsylum Casework And Research229945190001
    KAI-KAI, Mary Agatha, Dr
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Director
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishAcademic203163380001
    KAIFALA, Gabriel Bamie, Dr
    South Portland Street
    G9 5JL Glasgow
    37
    Lanarkshire
    Uk
    Director
    South Portland Street
    G9 5JL Glasgow
    37
    Lanarkshire
    Uk
    ScotlandBritishNone173541580001
    LOGAN, Alan David Keith
    EH51 9RP By Bo'Ness
    Old Kinglass Farmhouse
    West Lothian
    Director
    EH51 9RP By Bo'Ness
    Old Kinglass Farmhouse
    West Lothian
    BritishRetired Company Director130440110001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    10 nov 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0