CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC281105 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
- Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
¿Dónde se encuentra CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BOWMOR HOMES LIMITED | 17 jun 2005 | 17 jun 2005 |
| HMS (606) LIMITED | 04 mar 2005 | 04 mar 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Stuart Peter Hood como director el 17 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Colin John Spain como director el 17 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 38 páginas | AA | ||
Nombramiento de Tik San Dickson Leung como director el 28 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Javier Francisco Serrano Alonso como director el 13 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Patrick George Dowdall como director el 14 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Daniel Frank Hobson como director el 14 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Ross William Peter Fenton como director el 11 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Heather Lindsay Donald como director el 11 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Bernard Lilley como director el 03 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Stephen Lewis Harmon Packwood como director el 03 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr Javier Serrano el 12 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Benjamin Michael Burgess como director el 06 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Paul Rule como director el 06 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 39 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Stuart Peter Hood el 31 oct 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Verity Anne Beckham como director el 03 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Fraser Masson como director el 03 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jeremy Williamson como director el 01 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ross William Peter Fenton como director el 01 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 38 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Bernard Michael O'connor como secretario el 01 ago 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
¿Quiénes son los directivos de CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'CONNOR, Bernard Michael | Secretario | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House | 312226110001 | |||||||
| BECKHAM, Verity Anne | Director | G2 6AY Glasgow 1 Waterloo Street | Scotland | British | 323775270001 | |||||
| BURGESS, Benjamin Michael | Director | First Floor, 1 Finsbury Avenue EC2M 2PF London Glil Infrastructure Llp England | England | British | 330475100001 | |||||
| DONALD, Heather Lindsay | Director | G2 6AY Glasgow, 1 Waterloo Street Scotland | Scotland | British | 326675940001 | |||||
| DOWDALL, Patrick George | Director | 5 Manchester Road M43 6SF Droylsden, Tameside Gmpf, Guardsman Tony Downes House United Kingdom | United Kingdom | British | 204823090002 | |||||
| LEUNG, Tik San Dickson | Director | EC2Y 5AU London 1 London Wall Place England | England | British | 341950860001 | |||||
| PACKWOOD, Stephen Lewis Harmon | Director | EC2Y 5AU London 1 London Wall Place England | England | British | 335167420001 | |||||
| SPAIN, Colin John | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Ireland | Irish | 343310990001 | |||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secretario | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House 200 Perthshire | British | 129227760001 | ||||||
| FAIRBAIRN, Sally | Secretario | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 193182970001 | |||||||
| HMS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow | 900004320001 | |||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BAKER, Alan | Director | 16 Harbourside Kip Village PA16 0BF Inverkip Renfrewshire | Scotland | Scottish | 103351610001 | |||||
| BREADY, Christopher | Director | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 United Kingdom | Scotland | British | 279654840001 | |||||
| COWIE, Steven Alexander | Director | 42 Divert Road PA19 1EE Gourock | Scotland | British | 77680370001 | |||||
| DONALDSON, Peter Symons | Director | PH16 5NF Pitlochry Clunie Power Station Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131456210001 | |||||
| DOWLING, Paul Cyril | Director | Weston Carrick Brook, Eadestown Naas County Kildare Ireland | Ireland | Irish | 111811130002 | |||||
| FLYNN, Donal Francis | Director | 3 Whitebeam Avenue Clonskeagh IRISH Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | 126967800001 | |||||
| GARDNER, David | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House United Kingdom | United Kingdom | British | 126262860001 | |||||
| GIBLIN, Caoimhe Mary | Director | South County Business Park Leopardstown 18 Dublin Red Oak South Ireland | Ireland | Irish | 153538670001 | |||||
| HEYES, Simon Murray | Director | Turretbank Road PH7 4LN Crieff 8 Perthshire | United Kingdom | British | 189332050001 | |||||
| HOBSON, Daniel Frank | Director | 1 Finsbury Avenue EC2M 2PF London 1st Floor England | United Kingdom | British | 205998160001 | |||||
| HOOD, Stuart Peter | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Scotland | British | 329647650001 | |||||
| LANNEN, Neil | Director | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | Scottish | 245981230001 | |||||
| LILLEY, Stephen Bernard | Director | 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London Burdett House England | United Kingdom | British | 115160890003 | |||||
| MASSON, Fraser | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Scotland | British | 295678810001 | |||||
| MCADAM, Martin | Director | 35 Glen Lawn Drive The Park IRISH Cabinteely Dublin Ireland | Irish | 94415780001 | ||||||
| MONJE DIEZ, Victor Sergio | Director | 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London Burdett House United Kingdom | England | Spanish | 227011270001 | |||||
| MURPHY, Senan | Director | 2 Cranford Terenure Road West IRISH Dublin 6w Ireland | Irish | 95157200001 | ||||||
| NICOL, Colin Clarke | Director | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 117786710001 | |||||
| O'REGAN, Barry | Director | South County Business Park Leopardstown 18 Dublin Red Oak South Ireland | Ireland | Irish | 224298630001 | |||||
| O'REGAN, Barry | Director | Ravenscourt Office Park Sandyford Dublin 18. Airtricity House Ireland | Ireland | Irish | 224298630001 | |||||
| ORD, Jonathan Nicholas | Director | 169 Union Street SE1 0LL London Local Pensions Partnership Investments England England | England | British | 215036830001 | |||||
| PORTER, Jason Paul | Director | 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London Burdett House United Kingdom | United Kingdom | British | 203280610001 | |||||
| PORTER, Jason Paul | Director | 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London Burdett House England | United Kingdom | British | 203280610001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLYDE WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greencoat Uk Wind Holdco Limited | 26 jun 2018 | - 28 Eastcastle Street W1W 8DH London 27 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Greencoat Uk Wind Holdco Limited | 06 abr 2016 | - 28 Eastcastle Street W1W 8DH London 27 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Sse Renewables Onshore Windfarm Holdings Limited | 06 abr 2016 | 25 Great Victoria Street BT2 7AQ Belfast Millennium House Northern Ireland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0