EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC285404 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOTHIAN SHELF (287) LIMITED | 27 may 2005 | 27 may 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Dylan Fletcher como director el 12 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alison Groat como director el 12 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Craig Alexander Thomson como director el 12 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Claire Agnes Mcinally como director el 12 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Modification des détails de Pfi Infrastructure Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del secretario Infrastructure Managers Limited el 17 feb 2025 | 1 páginas | CH04 | ||
Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Cameron Mclure como director el 31 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de David Niall Smith como director el 20 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Alison Groat como director el 20 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alasdair Campbell como director el 09 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Neil Andrew Woodburn como director el 09 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del secretario Infrastructure Managers Limited el 15 dic 2023 | 1 páginas | CH04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN United Kingdom a C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN el 12 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF a Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN el 12 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de John Wrinn como director el 30 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Carl Harvey Dix como director el 30 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secretario corporativo | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| CAVILL, John Ivor | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 152521640006 | |||||||||
| DIX, Carl Harvey | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 305019190001 | |||||||||
| DONN, Michael Andrew | Director | 40 Princes Street EH2 2BY Edinburgh Aberdeen Asset Management Plc United Kingdom | Scotland | British | 108352120001 | |||||||||
| HEATH, James Christopher | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 122413700002 | |||||||||
| MCINALLY, Claire Agnes | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 167317960001 | |||||||||
| MCLURE, Cameron | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 318253280001 | |||||||||
| THOMSON, Craig Alexander | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 170356700001 | |||||||||
| WOODBURN, Neil Andrew | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | England | British | 137607780003 | |||||||||
| SMYTH, Pamela June | Secretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh Lothian | British | 65057960002 | ||||||||||
| WILSON, Gordon James | Secretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh Lothian | British | 169498380001 | ||||||||||
| BURNESS LLP | Secretario corporativo | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||||||
| ANDERSON, Derek Orr | Director | 9 The Spinneys KY11 9SL Dalgety Bay Fife | Scotland | British | 161345590001 | |||||||||
| BAXTER, Mark | Director | Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh 2 Midlothian | United Kingdom | British | 121315740001 | |||||||||
| BRADLEY, Victoria Louise | Director | Churchill Place E14 5HP London 1 | United Kingdom | British | 150074660001 | |||||||||
| BREMNER, Alexander George | Director | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom | Scotland | British | 152806580003 | |||||||||
| BREMNER, Alexander George | Director | Inch Avenue Aberdour KY3 0TF Burntisland 3 Fife | Scotland | British | 152806580001 | |||||||||
| BRUCE, Andrew David | Director | 147 Constitution Street EH6 7AD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 111589290001 | |||||||||
| CAMPBELL, Alasdair | Director | Level 7 One Bartholomew Close, Barts Square ECA 7BL London Infrared Capital Partners Limited United Kingdom | Scotland | British | 215915630001 | |||||||||
| ELLIOT, John Christian | Director | 1 Hope Terrace EH9 2AP Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 184790001 | |||||||||
| FLETCHER, Dylan | Director | Croftlea 50 Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4RS Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 82097010004 | |||||||||
| GARCIA, Carlos Abuin | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | Spanish | 239719320001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Director | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GILMOUR, David Fulton | Director | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd | United Kingdom | British | 158508150001 | |||||||||
| GROAT, Alison | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | Scotland | British | 316594510001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 Uk | England | British | 170508700001 | |||||||||
| JACK, Ronald Gilfillan | Director | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom | Scotland | British | 76530270002 | |||||||||
| MACKIE, Robin Smith | Director | Katiesdyke New Fargie PH2 9QT Glenfarg Perthshire | Scotland | British | 522870002 | |||||||||
| MCVEY, Philip | Director | Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh 2 Midlothian | United Kingdom | British | 99001530002 | |||||||||
| PARK, James Leil | Director | Westfield 8 Donaldfield Road PA11 3JJ Bridge Of Weir Renfrewshire | Scotland | British | 114897490001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 Uk | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Director | 57 Kettilstoun Mains EH49 6SH Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Director | 57 Kettilstoun Mains EH49 6SH Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||
| SCOTT, Alan Philip | Director | Harlaw Bank Balerno EH14 7HR Edinburgh 2 | Scotland | British | 182952430001 | |||||||||
| SMITH, David Niall | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 197175530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfi Infrastructure Finance Limited | 06 abr 2016 | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited | 06 abr 2016 | Churchill Place Canary Wharf E14 5HJ London 20 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Holdings Limited | 06 abr 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0