D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED

D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaD.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC286123
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VALAD CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED18 sept 200718 sept 2007
    TEESLAND CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED24 may 200724 may 2007
    SCARBOROUGH CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED23 jun 200523 jun 2005
    MM&S (4084) LIMITED13 jun 200513 jun 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    14 páginas4.26(Scot)

    Cese del nombramiento de Martyn James Mccarthy como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 15 dic 2014

    LRESEX

    Cambio de datos del director Martyn James Mccarty el 31 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    24 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 jun 2014

    Estado de capital el 20 jun 2014

    • Capital: EUR 115,399,240
    SH01

    Cambio de datos del director Valsec Director Limited el 01 jul 2013

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del director Martyn James Mccarty el 01 jul 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed valad continental partners europe LIMITED\certificate issued on 06/02/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    06 feb 2013

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 04 ene 2013

    RES15

    ¿Quiénes son los directivos de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director corporativo
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5307786
    102622300002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Director
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    British73218540001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    GERVASI, Pierre Rene
    16 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    95600
    France
    Director
    16 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    95600
    France
    French109596850001
    KENNEDY, Johann
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish119260990001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    Avenue Louise 541 Ascot Apartments
    Square Du Bois 1050 Ixelles
    Bruxelles
    Belgium
    Director
    Avenue Louise 541 Ascot Apartments
    Square Du Bois 1050 Ixelles
    Bruxelles
    Belgium
    British109250000006
    MCCARTHY, Martyn James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126149680008
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Director
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MORE, Gordon Lennie Truman
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    Director
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    British111414890001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Director
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    Warrington Crescent
    W9 1ED London
    9
    Director
    Warrington Crescent
    W9 1ED London
    9
    EnglandBritish69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Director
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director corporativo
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    ¿Tiene D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 23 mar 2012
    Entregado el 29 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 mar 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 10 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All related assets pertaining to the present shares:. Please see form for details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 10 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All related assets pertaining to the present shares:. Please see form for details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Amendment agreement
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 03 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Pursuant to the share pledge, the pledgor irrevocably and unconditionally granted a continuing first-ranking pledge and security interest over the pledged assest (please see form).
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 03 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    A pledge over the pledged shares that they hold in the company representing (100)% of the share capital of the company (please see form).
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 02 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 30 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Restated share pledge
    Creado el 19 ene 2006
    Entregado el 26 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    As a continuing security for the prompt payment, discharge and performance in full when due of the secured obligations, the pledgor hereby pledges in favour of the secured parties a first priority security interest in all of the pledgors rights, title and interest in and to the shares and the related rights.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 ene 2006Registro de un cargo (410)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 24 oct 2005
    Entregado el 11 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    As a continuing security for prompt payment, discharge and performance in full when due of the secured obligations, the pledgor pledges in favour of the secured parties, and hereby grants the secured parties a first priority security interest in, all of the pledgors rights, title and interest in and to the shares and the related rights.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transacciones
    • 11 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 21 oct 2005
    Entregado el 07 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledged assets (see form 410 paper apart).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transacciones
    • 07 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 21 oct 2005
    Entregado el 07 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledged assets (see form 410 paper apart).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transacciones
    • 07 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 21 oct 2005
    Entregado el 29 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 oct 2005Registro de un cargo (410)
    • 29 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS EUROPE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 dic 2014Inicio de la liquidación
    11 may 2016Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0