D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED

D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaD.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC286340
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VALAD CONTINENTAL PARTNERS LIMITED18 sept 200718 sept 2007
    TEESLAND CONTINENTAL PARTNERS LIMITED24 may 200724 may 2007
    SCARBOROUGH CONTINENTAL PARTNERS LIMITED30 jun 200530 jun 2005
    SCARBOROUGH CONTINENTAL PARTNERS TOPCO LIMITED23 jun 200523 jun 2005
    M M & S (4085) LIMITED17 jun 200517 jun 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    14 páginasLIQ13(Scot)

    Cambio de datos del secretario Cromwell Corporate Secretarial Limited el 07 sept 2020

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor Exchange Place 3 3 Semple Street Edinburgh EH3 8BL a Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA el 07 sept 2020

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 23 ene 2020

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 16 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2863400011

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC2863400010

    1 páginasMR04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    20 páginasAA

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr James Edward Maddy como director el 15 feb 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Claire Treacy como director el 15 feb 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 16 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2017

    28 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 ene 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registroSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director corporativo
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro5307786
    102622300003
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Director
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    British73218540001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    GERVASI, Pierre Rene
    19 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    FOREIGN France
    Director
    19 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    FOREIGN France
    French111647700001
    HURLEY, Peter Edmund
    Nield Avenue
    NSW 2093 Balgowlah
    16
    Australia
    Director
    Nield Avenue
    NSW 2093 Balgowlah
    16
    Australia
    AustraliaAustralian121515110004
    KENNEDY, Johann
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish119260990001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Gary John
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    Director
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    British133465930001
    MCCABE, Kevin Charles
    Level 20
    5 Place Du Champs De Mars
    1050 Brussels
    Bastion Tower
    Belgium
    Director
    Level 20
    5 Place Du Champs De Mars
    1050 Brussels
    Bastion Tower
    Belgium
    BelgiumBritish109250000002
    MCCARTHY, Martyn James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126149680033
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Director
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MORE, Gordon Lennie Truman
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    Director
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    British111414890001
    SEDDON, David Robert Armour
    81 East Sheen Avenue
    SW14 8AX London
    Director
    81 East Sheen Avenue
    SW14 8AX London
    England & WalesBritish141822480001
    SHIELS, Paul
    Level 1,Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Europa Ltd
    Director
    Level 1,Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Europa Ltd
    GermanyBritish136589450001
    SIME, Fraser Mckenzie
    115 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Midlothian
    Director
    115 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Midlothian
    British111866670001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Director
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director corporativo
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Director designado corporativo
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    D.U.K.E. Property Holdings (Uk) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06 abr 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro4382219
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 03 feb 2015
    Entregado el 19 feb 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 feb 2015Registro de una carga (MR01)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 03 feb 2015
    Entregado el 19 feb 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 feb 2015Registro de una carga (MR01)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 23 mar 2012
    Entregado el 29 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Right, title and interest in the charged assets. See form for further details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 mar 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 mar 2012
    Entregado el 29 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 mar 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 mar 2012
    Entregado el 02 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 abr 2012Registro de un cargo (MG01s)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creado el 01 jul 2009
    Entregado el 13 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery - see form 410 for full details.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 jul 2009Registro de un cargo (410)
    • 18 ene 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 01 jul 2009
    Entregado el 13 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 jul 2009Registro de un cargo (410)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Pledge over receivables agreement
    Creado el 27 feb 2008
    Entregado el 14 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledged receivables.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 mar 2008Registro de un cargo (410)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 21 oct 2005
    Entregado el 08 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1 ordinary £1 share in scarborough continental partners UK limited and all further or additional stocks, shares and other securities. All dividends, interest or distribution.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 21 oct 2005
    Entregado el 04 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The existing shares and any assets to which the company is entitled at the date of the share pledge any other further shares and/or assets to which the company becomes entitled after the date of the share pledge in accordance with the provisions of the share pledge.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 21 oct 2005
    Entregado el 29 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 oct 2005Registro de un cargo (410)
    • 13 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    03 mar 2022Fecha prevista de disolución
    23 ene 2020Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0